ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC262695 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Adresse du siège social | Regency House Crossgates Road Halbeath KY11 7EG Dunfermline Fife |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02s | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 15 déc. 2011
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Norman Yardley le 08 juil. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Norman Yardley en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 17 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Dominic Joseph Lavelle le 06 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secrétaire | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147808770001 | |||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| YARDLEY, Norman | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 153904770001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Secrétaire | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secrétaire | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MOTION, Michelle Hunter | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
| BURNESS LLP | Secrétaire | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
| BROWN, Andrew | Administrateur | 5 Strathcarron Way PA2 7AE Paisley Renfrewshire | Scotland | Scottish | 91209410001 | |||||
| DIPRE, Remo | Administrateur | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| GAFFNEY, David | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Administrateur | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Administrateur | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEITCH, Gerald | Administrateur | 24 Mary Fisher Crescent G82 1BF Dumbarton Dunbartonshire | British | 110231420001 | ||||||
| MACLEOD, Angus Iain | Administrateur | 81 Fereneze Avenue Clarkston G76 7RX Glasgow | United Kingdom | British | 57667380001 | |||||
| MOTION, Michelle Hunter | Administrateur | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | United Kingdom | British | 78545300002 | |||||
| D.W. DIRECTOR 1 LIMITED | Administrateur désigné | 4th Floor Saltire Court, 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900021330001 |
ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 30 déc. 2008 Livré le 14 janv. 2009 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 30 déc. 2008 Livré le 08 janv. 2009 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 09 déc. 2004 Livré le 24 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Irregularly shaped area of ground lying with I the parish of kilmacolm in the county of renfrew extending to 20.112 acres--see document for full schedule listing. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 03 déc. 2004 Livré le 11 déc. 2004 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0