ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED

ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC262695
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MANOR KINGDOM (BRIDGE OF WEIR) LIMITED26 avr. 200426 avr. 2004
    DUNWILCO (1128) LIMITED29 janv. 200429 janv. 2004

    Quels sont les derniers comptes de ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approval of transfer of interests 14/12/2011
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 févr. 2012

    État du capital au 06 févr. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 15 déc. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Norman Yardley le 08 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Nomination de Norman Yardley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    17 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dominic Joseph Lavelle le 06 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808770001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153904770001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secrétaire
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    BROWN, Andrew
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandScottish91209410001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEITCH, Gerald
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    British110231420001
    MACLEOD, Angus Iain
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    Administrateur
    81 Fereneze Avenue
    Clarkston
    G76 7RX Glasgow
    United KingdomBritish57667380001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Administrateur
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritish78545300002
    D.W. DIRECTOR 1 LIMITED
    4th Floor
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    4th Floor
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900021330001

    ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 déc. 2004
    Livré le 24 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Irregularly shaped area of ground lying with I the parish of kilmacolm in the county of renfrew extending to 20.112 acres--see document for full schedule listing.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 03 déc. 2004
    Livré le 11 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0