KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED

KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC302980
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    231 St Vincent Street
    G2 5QY Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MANOR KINGDOM FINANCE LIMITED05 juin 200605 juin 2006
    LOTHIAN SHELF (401) LIMITED25 mai 200625 mai 2006

    Quels sont les derniers comptes de KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de Homelea House Faith Avenue Quarriers Village Bridge of Weir Renfrewshire PA11 3SX Scotland le 16 sept. 2011

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JL le 12 sept. 2011

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Craig William Mckinnon en tant que directeur le 09 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juil. 2011

    État du capital au 15 juil. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approve share purchase of entire capital of manor kingdom finance investments LTD 21/01/2011
    RES13

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Nomination de Craig William Mckinnon en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG03s

    Certificat de changement de nom

    Company name changed manor kingdom finance LIMITED\certificate issued on 25/03/11
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name25 mars 2011

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Nomination de Mr David Gaffney en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    24 nov. 2023Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 24/11/2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Changement d'adresse du siège social de Regency House Crossgates Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 7EG le 23 mars 2011

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Joanne Massey en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Neil Fitzsimmons en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Colin Lewis en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Divers

    Section 519 statement
    1 pagesMISC

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GAFFNEY, David
    Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollarbeg
    21
    Clackmannanshire
    Scotland
    Administrateur
    Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollarbeg
    21
    Clackmannanshire
    Scotland
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809060001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secrétaire
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    INGRAM, David Colin
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    British109149390001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    MCKINNON, Craig William
    Newtonlea Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QF Glasgow
    53
    Scotland
    Administrateur
    Newtonlea Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QF Glasgow
    53
    Scotland
    ScotlandBritish14490650002
    MCKINNON, Craig William
    53 Newtonlea Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QF Glasgow
    Administrateur
    53 Newtonlea Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QF Glasgow
    ScotlandBritish14490650002
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Administrateur
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritish78545300002
    BURNESS (DIRECTORS) LIMITED
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Administrateur désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900019120001

    KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 05 oct. 2006
    Livré le 19 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0