Robert Anthony BAILEY - Page 2
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Robert |
Deuxième prénom | Anthony |
Nom de famille | BAILEY |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 6 |
Inactif | 24 |
Démissionné | 70 |
Total | 100 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE ROYAL GP ALLIANCE LIMITED | 29 oct. 2014 | 29 oct. 2014 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Trentham Business Quarter ST4 8GB Stoke On Trent G1 Bellringer Road Staffordshire | England | British |
ARUNA MEDICAL LLP | 02 mai 2013 | 20 juin 2013 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | c/o Rjs Solicitors Trentham Business Quarter ST4 8GB Stoke On Trent G1 Bellringer Road Staffordshire | England | ||
BELGRAVE CENTRE LIMITED | 23 janv. 2012 | 21 déc. 2012 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Bellringer Road Trentham Business Quarter ST4 8GB Stoke On Trent G1 Staffordshire England | England | British |
SG FURNITURE LIMITED | 24 mai 2012 | 06 juin 2012 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | c/o Rj Staffordshire Ltd Bellringer Road Trentham ST4 8GB Stoke-On-Trent G1 Staffordshire United Kingdom | England | British |
THE BARRACKS TRUST LIMITED | 08 nov. 2010 | 31 déc. 2011 | Active | None | Administrateur | Ashley TF9 4PW Market Drayton Dale Farm Shropshire | England | British |
JESSE SHIRLEY MINERALS LIMITED | 13 mai 2011 | 31 oct. 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Mount Road ST15 8UZ Stone Edge Hill Staffordshire | England | British |
DELPHI BUSINESS SERVICES LIMITED | 13 déc. 2010 | 05 sept. 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Bagnall Street Hanley ST1 3AQ Stoke-On-Trent 8-10 Staffordshire | England | British |
PB NEWCO LIMITED | 13 déc. 2010 | 28 avr. 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Bagnall Street Hanley ST1 3AQ Stoke-On-Trent 8-10 Staffordshire | England | British |
DESIGNMYESHOP.COM LIMITED | 13 déc. 2010 | 23 mars 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Chapel Lane Harome YO62 5JL York Mulberry House North Yorkshire | England | British |
HAJCO DIRECTORS LIMITED | 27 sept. 2005 | 11 nov. 2010 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
HAJCO 380 LIMITED | 31 mars 2009 | 29 oct. 2010 | Active | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
HAJCO SECRETARIES LIMITED | 27 sept. 2005 | 01 oct. 2010 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
NCA ENTERPRISES LIMITED | 22 mai 2009 | 30 sept. 2010 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
HACKING ASHTON LLP | 01 mai 2004 | 30 sept. 2010 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | Beechtree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke-On-Trent | England | ||
EFFECTIVE CONSUMABLE SOLUTIONS (UK) LIMITED | 12 juin 2009 | 29 juin 2009 | Active | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
CATERHAM MARBLE AND GRANITE LIMITED | 13 févr. 2006 | 27 mars 2009 | Active | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
CATERHAM FIREPLACES LIMITED | 01 déc. 2005 | 27 mars 2009 | Active | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
PENKHULL HOMES LIMITED | 03 mars 2008 | 18 août 2008 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
LIYELL LIMITED | 17 mai 2007 | 01 mars 2008 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
BRISTOL & LONDON PLC | 22 mars 2002 | 02 janv. 2008 | Liquidation | Director | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
BRISTOL & LONDON PLC | 15 nov. 1999 | 02 janv. 2008 | Liquidation | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
D & G COACH & BUS LIMITED | 17 mai 2007 | 21 sept. 2007 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
NORTH STAFFORDSHIRE URGENT CARE (HOLDINGS) LIMITED | 07 déc. 2005 | 25 juil. 2006 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
COLD NORTON DEVELOPMENTS LIMITED | 08 mai 2003 | 04 avr. 2006 | Active | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | ||
THE BURSLEM REGENERATION COMPANY LIMITED | 17 févr. 2003 | 12 nov. 2004 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
THE TALBEX GROUP LIMITED | 16 sept. 1997 | 30 sept. 2004 | Dissoute | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | ||
HEATONS SECRETARIES LIMITED | 21 nov. 2002 | 19 avr. 2004 | Active | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
HEATONS DIRECTORS LIMITED | 21 nov. 2002 | 19 avr. 2004 | Active | Director | Administrateur | 5 The Thistles Thistlebury Avenue ST5 2HR Newcastle Staffordshire | England | British |
DHM ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | 10 mars 1999 | 01 avr. 2004 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
NOVELSTACK LIMITED | 12 janv. 1998 | 30 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | 5 The Thistles Thistlebury Avenue ST5 2HR Newcastle Staffordshire | British | ||
CHRIS JARAM DEVELOPMENTS (CNF) LIMITED | 23 janv. 2004 | 23 janv. 2004 | Active | Solicitor | Secrétaire | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | British | |
THE BURSLEM REGENERATION COMPANY LIMITED | 17 févr. 2003 | 19 mars 2003 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Beech Tree Cottage 51 Longton Road Barlaston ST12 9AR Stoke On Trent Staffordshire | England | British |
HEATONS SECRETARIES LIMITED | 05 juil. 2002 | 21 nov. 2002 | Active | Secrétaire | 5 The Thistles Thistlebury Avenue ST5 2HR Newcastle Staffordshire | British | ||
HEATONS DIRECTORS LIMITED | 03 juil. 2002 | 21 nov. 2002 | Active | Secrétaire | 5 The Thistles Thistlebury Avenue ST5 2HR Newcastle Staffordshire | British | ||
COLD NORTON DEVELOPMENTS LIMITED | 05 juil. 2002 | 01 oct. 2002 | Active | Secrétaire | 5 The Thistles Thistlebury Avenue ST5 2HR Newcastle Staffordshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0