Suzanne BREWER - Page 128
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Suzanne |
Nom de famille | BREWER |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 6691 |
Total | 6695 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYBRIDGE CHEMICAL COMPANY LIMITED | 27 juin 1997 | 27 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
PROFESSIONAL PIZZA COMPANY LIMITED | 26 juin 1997 | 26 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
HORNE AND MEREDITH PROPERTIES LIMITED | 26 juin 1997 | 26 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
PALACE DESIGNS LIMITED | 27 mai 1997 | 26 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
A.D. HYDE LIMITED | 24 juin 1997 | 24 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
ARCADIA TECHNOLOGY LIMITED | 01 avr. 1997 | 24 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
J W CONSTRUCTION CONSULTANCY LIMITED | 23 juin 1997 | 23 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
VERALU CHIVAL LIMITED | 23 juin 1997 | 23 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
STRUCOM LIMITED | 20 juin 1997 | 20 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
KELAYS SPORT & LEISURE LIMITED | 18 juin 1997 | 18 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
TANGLEY PARK DAY NURSERY LIMITED | 17 juin 1997 | 17 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
POWER PLUS ELECTRIC MOTORS LIMITED | 23 janv. 1997 | 17 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
RTC NETWORKING LIMITED | 16 juin 1997 | 16 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
MAXI WASTE LIMITED | 16 juin 1997 | 16 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
SPECIALIST WATER SERVICES LIMITED | 16 juin 1997 | 16 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
PROLINE BUILDING COMPANY LIMITED | 16 avr. 1997 | 16 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
GORDON WEBB DEVELOPMENTS LIMITED | 13 juin 1997 | 13 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
GENERAL MAGNETIC LIMITED | 13 juin 1997 | 13 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
M.W. FASHIONS LIMITED | 13 juin 1997 | 13 juin 1997 | Liquidation | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
FLUENT EVENTS LIMITED | 12 juin 1997 | 12 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
HIGHFIELD (BIRMINGHAM) LIMITED | 12 juin 1997 | 12 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
KINGPIN COMMUNICATIONS LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
EMPLOYEE PURCHASE FACILITY LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
SHERIDAN ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
LOUP COMBLE LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
JAMES LEIGH RUBBER AND PLASTICS LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
KC & CO (COVENTRY) LIMITED | 11 juin 1997 | 11 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
THE APEDALE HERITAGE CENTRE | 10 juin 1997 | 10 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
DAS CERTIFICATION LIMITED | 10 juin 1997 | 10 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
BROADWAY EFL LIMITED | 10 juin 1997 | 10 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
SHELVING DISTRIBUTION LIMITED | 27 mai 1997 | 10 juin 1997 | Liquidation | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
M.R.M. CONTRACTORS LIMITED | 09 juin 1997 | 09 juin 1997 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
PHIL GIBSON PLASTERING CONTRACTORS LIMITED | 06 juin 1997 | 06 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
SERGENT MAJOR COMPANY LIMITED | 06 juin 1997 | 06 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
PREMIER RAIL SERVICES LIMITED | 05 juin 1997 | 05 juin 1997 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0