Suzanne BREWER - Page 158
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Suzanne |
Nom de famille | BREWER |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 6691 |
Total | 6695 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTH FRANCE PROPERTIES LIMITED | 10 juil. 1995 | 10 juil. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
LEGAL-LINK LIMITED | 15 juin 1995 | 05 juil. 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
JDM DEVELOPMENTS LIMITED | 05 juil. 1995 | 05 juil. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
EAGLE AIR CORPORATION LIMITED | 05 juil. 1995 | 05 juil. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
EXCEL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL LIMITED | 05 juil. 1995 | 05 juil. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
MARRICK COMMUNICATIONS LIMITED | 05 juil. 1995 | 05 juil. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
XENON TECHNOLOGY LIMITED | 18 avr. 1995 | 03 juil. 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
INTERTRADE CONSULTANTS LIMITED | 12 avr. 1995 | 03 juil. 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
THE RIGHT SOLUTION LIMITED | 01 juin 1995 | 30 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
CARS DIRECT LIMITED | 10 nov. 1994 | 30 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
BROADFIELD & PARTNERS LIMITED | 29 juin 1995 | 29 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
CLEVECRETE CONCRETE LIMITED | 29 juin 1995 | 29 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
NU-WELD ENGINEERING SERVICES LIMITED | 27 juin 1995 | 27 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
DATAFLOW CONTRACTS LIMITED | 27 juin 1995 | 27 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
STEWART RUSSELL ASSOCIATES LIMITED | 27 juin 1995 | 27 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
FOUR SEASONS PROPERTIES LIMITED | 22 juin 1995 | 27 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
C A DESIGN LTD | 27 juin 1995 | 27 juin 1995 | Liquidation | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
IMPRINT COLOUR PRINTERS LIMITED | 23 juin 1995 | 23 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
D.C. ENGINEERING (WIRRAL) LIMITED | 20 juin 1995 | 20 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
CONSERVATORY COMPONENTS LIMITED | 19 juin 1995 | 19 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
HUGO NICOLLE GARDEN DESIGN LIMITED | 19 juin 1995 | 19 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
BLUEPRINT DEVELOPMENTS LIMITED | 01 juin 1995 | 19 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
INSIGHT BUILDERS LIMITED | 12 avr. 1995 | 19 juin 1995 | Liquidation | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
WATERLOO CORPORATION LIMITED | 07 avr. 1995 | 16 juin 1995 | Liquidation | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
CONDOR INTERIORS LIMITED | 14 juin 1995 | 14 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
MAGICAL SOLUTIONS LIMITED | 14 juin 1995 | 14 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
ACRELEA LIMITED | 13 juin 1995 | 13 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
HARRISON CLOSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 12 juin 1995 | 12 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
CYLINDER TESTING & SALES (U.K.) LIMITED | 12 juin 1995 | 12 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
GEORGES TRADITION LIMITED | 12 juin 1995 | 12 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
THE REPTILE MASTERS LIMITED | 07 avr. 1995 | 09 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
BLACKFRIARS CONSULTANTS LIMITED | 13 mars 1995 | 08 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
TRISTAR TELEVISION LIMITED | 07 juin 1995 | 07 juin 1995 | Active | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
KALAR TEXTILE LIMITED | 07 juin 1995 | 07 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | ||
GLOBAL EXHIBITIONS LIMITED | 06 juin 1995 | 06 juin 1995 | Dissoute | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British |
Précédent23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192Suivant
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0