Paul Gordon GRAEME - Page 13
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Paul |
Deuxième prénom | Gordon |
Nom de famille | GRAEME |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 1500 |
Total | 1506 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOLOGICAL ENERGY EUROPE LTD | 29 mars 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
PENNYROCK DESIGNS LIMITED | 26 mars 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CHILBURY LIMITED | 20 mars 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
LEDGERGATE LIMITED | 17 mars 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
LAKECOVE SOLUTIONS LIMITED | 14 mars 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
ISLANDBAY SOLUTIONS LIMITED | 07 mars 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
SWINGBROOK CONSTRUCTION LIMITED | 18 févr. 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
BRAMCOTE MANAGEMENT LIMITED | 06 févr. 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
HILLSPITE VENTURES LIMITED | 29 janv. 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
AVONBAY ASSOCIATES LIMITED | 23 janv. 2008 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
HAWSTEAD LIMITED | 10 déc. 2007 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
SWINGBROOK LIMITED | 31 oct. 2007 | 07 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
QUINTESSENTIAL WIRRAL LIMITED | 31 mars 2008 | 31 mars 2008 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
BUY TO LET FINANCE LIMITED | 18 mars 2008 | 31 mars 2008 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
SWANS KITCHENS & BATHROOMS LIMITED | 31 mars 2008 | 31 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
FOOD HYGIENE SOLUTIONS LIMITED | 31 mars 2008 | 31 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
MONEY DOCTOR LIMITED | 29 mars 2008 | 29 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
EAST WEST TAXIS LIMITED | 23 oct. 2007 | 28 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
TOTAL CLIMATE SOLUTIONS LIMITED | 25 mars 2008 | 25 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
MOORVIEW DESIGNS LIMITED | 19 févr. 2008 | 25 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
NEVERMORE LIMITED | 20 mars 2008 | 20 mars 2008 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
SUPERCULTURE LIMITED | 20 mars 2008 | 20 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
BOXHALL DEVELOPMENTS LIMITED | 09 janv. 2008 | 18 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
APERO BARS LIMITED | 14 août 2007 | 17 mars 2008 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
GALAXYCAST LIMITED | 22 oct. 2007 | 17 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CORALBROOK SOLUTIONS LIMITED | 28 nov. 2007 | 13 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
SUTTON HEATING LIMITED | 11 mars 2008 | 11 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
THE OPERATORS LIMITED | 06 mars 2008 | 06 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
JENNER (CONTRACTORS) LIMITED | 05 mars 2008 | 05 mars 2008 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
HALOBRIDGE LIMITED | 25 févr. 2008 | 05 mars 2008 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
LONGBEACH LIMITED | 06 févr. 2008 | 05 mars 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
SOUTHWELL COUNTY HOMES LIMITED | 03 mars 2008 | 03 mars 2008 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CATER FRESH LIMITED | 29 févr. 2008 | 29 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
MID KENT FABRICATIONS LIMITED | 25 févr. 2008 | 25 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
THE EPC COMPANY ENERGY ASSESSMENTS LIMITED | 25 févr. 2008 | 25 févr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0