Paul Gordon GRAEME - Page 32
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Paul |
Deuxième prénom | Gordon |
Nom de famille | GRAEME |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 3 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 1500 |
Total | 1506 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEREUROPE (FURNITURE) LIMITED | 29 août 2006 | 29 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
TYSON SHAW FINE ART LIMITED | 29 août 2006 | 29 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
J W PAVING LIMITED | 29 août 2006 | 29 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
OLIVINA LIMITED | 24 août 2006 | 24 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
ROMALEX IT CONSULTING LIMITED | 24 août 2006 | 24 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
TRADITIONAL BUILDERS AND RENOVATORS LIMITED | 24 août 2006 | 24 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CLARITY PURE DESIGN LIMITED | 24 août 2006 | 24 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CREATIV PARTNERSHIP LIMITED | 24 août 2006 | 24 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CROFT HOME DEVELOPMENTS LIMITED | 23 août 2006 | 23 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
MARKS & LEE DEVELOPMENTS LIMITED | 23 août 2006 | 23 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CROSS COURIERS LIMITED | 22 août 2006 | 22 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CGS JOINERY LIMITED | 21 août 2006 | 21 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
STACEY HOMES SOUTHERN LIMITED | 18 août 2006 | 18 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
THE CREATIVE CONSULTANCY NETWORK LIMITED | 17 août 2006 | 17 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
A N A PROPERTY (SOUTHERN) LIMITED | 17 août 2006 | 17 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
PHARAOH DESIGNS (WEST MIDLANDS) LIMITED | 16 août 2006 | 16 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CLIVE LAMB MORTGAGES LIMITED | 16 août 2006 | 16 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
DAVIS CURTAINS LIMITED | 15 août 2006 | 15 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CLASS EXECUTIVES LIMITED | 15 août 2006 | 15 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CASTLEFORD RESOURCES LIMITED | 10 juil. 2006 | 15 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
CITY & URBAN (SHOREDITCH) LIMITED | 11 août 2006 | 11 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
53 ART LIMITED | 10 août 2006 | 10 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
SWEET SQUARED LIMITED | 09 août 2006 | 09 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
COOL INSTALL LIMITED | 07 août 2006 | 07 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
JARRIVE LIMITED | 04 août 2006 | 04 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
COOLER ROOMS LIMITED | 03 août 2006 | 03 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
TGT (UK) LIMITED | 03 août 2006 | 03 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
HONEY VISION LIMITED | 01 août 2006 | 03 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
K.G. LOGISTICS LIMITED | 01 août 2006 | 01 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
WATERMILL HOMES LIMITED | 31 juil. 2006 | 01 août 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
MATT HOLYOAK LIMITED | 01 août 2006 | 01 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
IONOSPHYRE MEDIA LIMITED | 01 août 2006 | 01 août 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
FAVERSHAM MOTORCYCLE TRAINING LIMITED | 18 juil. 2006 | 31 juil. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
GARGANEY ENTERPRISES LTD | 16 juin 2006 | 31 juil. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British | ||
HST DEVELOPMENTS LIMITED | 28 juil. 2006 | 28 juil. 2006 | Active | Secrétaire | Fairview Avenue Wigmore ME8 0QP Gillingham 61 Kent | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0