Isobel Mary NETTLESHIP - Page 3
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Isobel |
Deuxième prénom | Mary |
Nom de famille | NETTLESHIP |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 101 |
Total | 104 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHA LIMITED | 01 juin 2005 | 31 mai 2014 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
MORGAN SINDALL INVESTMENTS (LANCASHIRE FIRE STATIONS) LIMITED | 01 juin 2005 | 31 mai 2014 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
VIVID INTERIORS LIMITED | 09 févr. 2005 | 31 mai 2014 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
MORGAN EST RAIL LIMITED | 24 mars 2006 | 31 mai 2014 | Liquidation | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
MORGAN BETON AND MONIERBAU LIMITED | 01 juin 2005 | 31 mai 2014 | Liquidation | Secrétaire | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | British | ||
STANSELL LIMITED | 01 juin 2005 | 31 mai 2014 | Liquidation | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
COBALT PROJECT INVESTMENTS (TAYCARE) LIMITED | 15 févr. 2008 | 27 sept. 2013 | Active | Secrétaire | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
MANCHESTER HOUSING (MP TOPCO) LIMITED | 20 mars 2007 | 27 juin 2013 | Active | Solicitor | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | |
MANCHESTER HOUSING (MP SUBDEBT) LIMITED | 16 févr. 2007 | 27 juin 2013 | Active | Secrétaire | Market Place W1W 8AJ London Kent House 14-17 | British | ||
SLOUGH URBAN RENEWAL NOMINEE LIMITED | 19 oct. 2012 | 22 mars 2013 | Active | Secrétaire | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | British | ||
EQUITIX HEALTHCARE 2 (LIFT) LIMITED | 03 févr. 2005 | 20 juil. 2012 | Active | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
COMMUNITY SOLUTIONS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 21 sept. 2006 | 21 mars 2012 | Active | Secrétaire | House 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent | British | ||
BLUE LIGHT HOLDINGS LIMITED | 20 juin 2007 | 15 févr. 2012 | Active | Secrétaire | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
CSES (DORSET) LIMITED | 20 juin 2007 | 15 févr. 2012 | Active | Secrétaire | Kent House 14-17 Market Place London W1W 8AJ | British | ||
PFF (DORSET) LIMITED | 11 juin 2007 | 15 févr. 2012 | Active | Secrétaire | Kent House Market Place W1W 8AJ London | British | ||
DORSET EMERGENCY SERVICES PPP (HOLDINGS) LIMITED | 03 mai 2007 | 15 févr. 2012 | Active | Secrétaire | House 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent | British | ||
PRIMARY MEDICAL PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 01 juin 2005 | 19 janv. 2012 | Active | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
INHOCO 4129 LIMITED | 27 mars 2006 | 19 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
CSPC 3PD LIMITED | 25 janv. 2006 | 19 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
MEDI-CARE DEVELOPMENTS LIMITED | 01 juin 2005 | 19 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
D K PROPERTIES (WOOLSTON) LIMITED | 01 juin 2005 | 19 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
PRIMARY MEDICAL PROPERTY LIMITED | 22 mars 2005 | 19 janv. 2012 | Dissoute | Secrétaire | Kent House 14 - 17 Market Place W1W 8AJ London | British | ||
CLAYMORE ROADS (HOLDINGS) LIMITED | 01 juin 2005 | 05 sept. 2007 | Active | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
CLAYMORE ROADS LIMITED | 01 juin 2005 | 05 sept. 2007 | Active | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
ROADLEASE VEHICLES LIMITED | 01 janv. 2001 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
TRANSBUS HOLDINGS LIMITED | 31 juil. 2000 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
TRANSBUS INTERNATIONAL LIMITED | 08 nov. 1999 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
DUPLE (METSEC) LIMITED | 01 nov. 1999 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
DENNIS (ONE) LIMITED | 17 août 1999 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
00252237 LIMITED | 31 mars 1999 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
MP (NO.1) PLC | 22 mars 1999 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
MAYFLOWER AUTOMOTIVE PRODUCTS (U.K.) LIMITED | 22 mars 1999 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
THE MAYFLOWER CORPORATION PLC | 26 févr. 1999 | 28 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British | ||
MAYFLOWER VEHICLE SYSTEMS PLC | 22 févr. 1999 | 28 mai 2004 | Liquidation | Solicitor | Secrétaire | 22 Perrers Road W6 0EZ London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0