ANDERSON STRATHERN WS - Page 4
Dirigeant de société
Nom | ANDERSON STRATHERN WS |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 134 |
Total | 137 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
BUCCLEUCH BIOENERGY LIMITED | 23 déc. 2003 | 09 janv. 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
D.C. AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED | 30 janv. 2001 | 01 janv. 2004 | Active | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SUBWAY FORTH SAUCHIEHALL STREET LIMITED | 10 nov. 2003 | 19 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
CLICK SUPPLIES LIMITED | 24 sept. 2003 | 24 nov. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
TOPOSPHERE LIMITED | 02 mai 2002 | 18 août 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
BUCCLEUCH NATURAL FUELS LIMITED | 27 janv. 2003 | 23 juil. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
GRIFFIN WIND FARM LIMITED | 05 mars 2003 | 09 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
GREENPOWER (CARRAIG GHEAL) LIMITED | 05 mars 2003 | 09 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
GREENPOWER (BROADMEADOWS) LIMITED | 05 mars 2003 | 09 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
GREENPOWER (LITTLE LAW) LIMITED | 05 mars 2003 | 09 juin 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (HIGHLANDS) | 24 nov. 2000 | 29 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
BUCCLEUCH SCOTCH BEEF LIMITED | 27 janv. 2003 | 23 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (EDINBURGH) | 05 mars 2002 | 10 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
THE ST KILDA CLUB SHOP LIMITED | 27 janv. 2003 | 01 avr. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (FIFE) | 25 mars 2002 | 21 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
THISTLE STREET FASHIONS LIMITED | 20 déc. 2001 | 03 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SUBWAY FORTH EAST KILBRIDE LIMITED | 14 nov. 2002 | 06 févr. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SUBWAY FORTH BRUNTSFIELD LIMITED | 14 nov. 2002 | 06 févr. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SUBWAY FORTH LIMITED | 04 sept. 2002 | 12 nov. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SCOTMID-BETT (FOUNTAINBRIDGE) LIMITED | 18 sept. 2002 | 04 oct. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS (INGRAM STREET) LIMITED | 12 mars 2002 | 30 juin 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SIGNATURE KITCHENS LIMITED | 19 déc. 2000 | 12 juin 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED | 19 déc. 2000 | 12 juin 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
MANOR KINGDOM HOLDINGS LIMITED | 06 déc. 2000 | 12 juin 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SCOLOCATE TRUSTEE COMPANY LIMITED | 28 nov. 2000 | 21 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
AIRCRAFT ENGINEERS LIMITED | 05 déc. 2001 | 01 févr. 2002 | Active | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
FORAY HOMES LIMITED | 05 oct. 2001 | 23 oct. 2001 | Active | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
ROXBURGHE HOME IMPROVEMENTS LIMITED | 21 août 2001 | 12 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
THE UNION ADVERTISING AGENCY (LEEDS) LIMITED | 21 août 2001 | 23 août 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SCOTMID-MILLER (GREAT JUNCTION STREET) LIMITED | 02 août 2001 | 03 août 2001 | Active | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SCOTMID-MILLER (SOUTH QUEENSFERRY) LIMITED | 02 août 2001 | 03 août 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
SURFACTANT SOLUTIONS LIMITED | 20 juil. 2000 | 24 août 2000 | Dissoute | Secrétaire désigné | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh Midlothian |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0