SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00068014 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED?
- fabbricazione di macchine per la lavorazione degli alimenti, bevande e tabacco (28930) / Industrie manifatturiere
Dove si trova SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road SK8 5AE Cheadle Hulme United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| APV UK LIMITED | 13 giu 1995 | 13 giu 1995 |
| APV CORPORATION LIMITED | 31 mag 1989 | 31 mag 1989 |
| APV BAKER LIMITED | 05 gen 1988 | 05 gen 1988 |
| APV HALL LIMITED | 28 nov 1986 | 28 nov 1986 |
| HALL-THERMOTANK LIMITED | 20 nov 1900 | 20 nov 1900 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Building a Compass House, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9PY a C/O Spx Flow Europe Limited Part Ground Floor, Alexander House 4 Station Road Cheadle Hulme SK8 5AE in data 14 apr 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Eversecretary Limited come segretario in data 01 feb 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 25 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 26 ott 2020
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jaime Manson Easley il 15 mar 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 01 ott 2020
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 8 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Notifica di Spx Flow Europe Limited come persona con controllo significativo il 21 ago 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Cessazione di Spx International Limited come persona con controllo significativo il 21 ago 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 28 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Tsoris come amministratore in data 31 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Peter James Ryan come amministratore in data 31 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASLEY, Jaime Manson | Amministratore | 13320 Ballantyne Corporate Place Charlotte, Spx Corporation Nc 28277 United States | United States | American | 259841060001 | |||||
| RYAN, Peter James | Amministratore | Ballantyne Corporate Place 28277 Charlotte 13320 North Carolina United States | United States | American | 259841080001 | |||||
| COLES, Richard Paul Atwell | Segretario | 30 Devereux Road SL4 1JJ Windsor Berkshire | British | 3097780001 | ||||||
| MACDONALD, Robert Somerled | Segretario | Applegarth Cottage 108 Station Street Rippingale PE10 0TA Bourne Lincolnshire | British | 36879360001 | ||||||
| WARDEN, Georgina Louise | Segretario | 52a Banstead Road SM5 3NW Carshalton Beeches Surrey | British | 35901160003 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Portland House Bressenden Place SW1E 5BF London | 75491680003 | |||||||
| BAYS, James Claude | Amministratore | 28 Elmstone Road Fulham SW6 5TN London | American | 64404450001 | ||||||
| BERGSTROM, Craig Alan | Amministratore | 2303 Larkdale Drive Glenview Illinois 60025 Usa | American | 65644840002 | ||||||
| BRIGGS, Nigel David | Amministratore | 7 Burnmoor Meadow Finchampstead RG40 3TX Wokingham Ermewood House | England | British | 128796110002 | |||||
| CLAYTON, John Reginald William | Amministratore | Matley House Grange Lane, Little Dunmow CM6 3HY Great Dunmow Essex | England | British | 28326930001 | |||||
| COCHRANE, Adam Craven | Amministratore | 41 Highfield Drive UB10 8AW Uxbridge Middlesex | British | 54618590001 | ||||||
| DAVIES, Nigel James Maxwell | Amministratore | 3 Moat End Bierton HP22 5DW Aylesbury Buckinghamshire | British | 830730001 | ||||||
| DURUDOGAN, Haluk | Amministratore | Baynards Manor Hall Cox Green Road Rudgwick RH12 3AD West Sussex | American | 100741020002 | ||||||
| FENNY, Richard | Amministratore | Badgers Crossing Lower Wokingham Road RG45 6DB Crowthorne Berkshire | British | 28959250001 | ||||||
| FOX, James | Amministratore | Glenburn 8 The Barton KT11 2NJ Cobham Surrey | American | 67117700001 | ||||||
| FRENCH, Neil Peter Donaldson, Dr | Amministratore | Oakleaves 5 Barrington Park Gardens HP8 4SS Chalfont St. Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 166551820001 | |||||
| GOH, Ann Nee | Amministratore | 14 Handel Mansions 94 Wyatt Drive Barnes SW13 8AH London | Singaporean | 74854620001 | ||||||
| HARRIS, Brian | Amministratore | 5 Longthorpe Green PE3 6LS Peterborough | British | 61522200001 | ||||||
| HULL, Victoria Mary | Amministratore | 28 Stanford Road Kensington W8 5PZ London | United Kingdom | British | 77283810002 | |||||
| KENNERLEY, John Frank William | Amministratore | Old Westwick Chantry View Road GU1 3XW Guildford Surrey | United Kingdom | British | 69793560001 | |||||
| LILLY, Kevin L | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | American | 123401090002 | ||||||
| MACDONALD, Robert Somerled | Amministratore | 22 Foliot Street East Acton W12 0BQ London | British | 36879360002 | ||||||
| MANN, Roger | Amministratore | 13 Beverley Close Lingwood GU15 1HF Camberley Surrey | British | 36110750001 | ||||||
| MCCLUSKIE, Brian Andrew | Amministratore | The Black House Isle Of Thorns Lane RH16 7LA Chelwood Gate West Sussex | British | 113726560001 | ||||||
| O'LEARY, Patrick Joseph | Amministratore | 6524 Chipstead Lane Charlotte North Carolina 28277 Usa | United States | American | 61807850002 | |||||
| PARKINSON, Joseph Paul | Amministratore | 9 Greatford Gardens Greatford PE9 4PX Stamford Lincolnshire | British | 954060001 | ||||||
| REILLY, Michael Andrew | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 Usa | United States | American | 103500870001 | |||||
| SARNEY, George William, Dr | Amministratore | 50 Myopia Road 01860 Winchester Massachusetts Usa | Us Citizen | 53924890002 | ||||||
| SMELTSER, Jeremy Wade | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13320 Nc 28277 United States | United States | American | 163313000001 | |||||
| SPENCER, Rachel Louise | Amministratore | The Cottage Amy Lane HP5 1NB Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 64905580001 | |||||
| STROWGER, Clive | Amministratore | The Ridge Woldingham CR3 7AX Caterham High Veld Surrey | United Kingdom | British | 47292770001 | |||||
| THOM, James Demmink | Amministratore | Tollgate Cottage Turners Hill Road RH10 4HG Crawley Down West Sussex | British | 38683120002 | ||||||
| THOMAS, David Jeremy | Amministratore | 11 Coutts Crescent 13-23 St Albans Road NW5 1RF London | United Kingdom | British | 31354400001 | |||||
| TSORIS, Stephen | Amministratore | Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte 13320 North Carolina United States | United States | American | 197069810001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spx Flow Europe Limited | 21 ago 2019 | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2LY Didsbury Ocean House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Spx International Limited | 09 ago 2016 | Bridgewater Place Water Lane LS11 5DR Leeds Eversheds Llp United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Spx Flow Technology London Limited | 06 apr 2016 | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2LY Didsbury Ocean House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SPX FLOW TECHNOLOGY CRAWLEY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession to the global insurance security agreement | Creato il 08 dic 2004 Consegnato il 23 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights in respect of the agreement, fixed charge all amounts and rights in connection with the insurances,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession to the UK security agreement | Creato il 08 dic 2004 Consegnato il 23 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for the secured creditors (the security agent) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus letter of set off | Creato il 02 mar 2004 Consegnato il 10 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The bank may at any time and without notice combine or consolidate all or any of the accounts, and set-off or transfer any credit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0