00118632 LIMITED
Panoramica
Nome della società | 00118632 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00118632 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di 00118632 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova 00118632 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Yew Trees, Main Street North Aberford LS25 3AA West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di 00118632 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BODDIS (OLD HILL) LIMITED | 17 nov 1911 | 17 nov 1911 |
Quali sono gli ultimi bilanci di 00118632 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2012 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2013 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2011 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 00118632 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 01 ott 2016 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 15 ott 2016 |
Scaduto | Sì |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 00118632 LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per 00118632 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Mr Sean Christopher Wyndham-Quin come amministratore in data 15 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di John William Young Strachan Samuel come amministratore in data 17 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed bb engineering\certificate issued on 13/07/16 | pagine | CERTNM | ||||||||||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mag 2013
| 5 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Nomina di John William Young Strachan Samuel come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 2 pagine | AD02 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2008 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2007 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di 00118632 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENEW NOMINEES LIMITED | Segretario | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 41291250014 | |||||||
WYNDHAM-QUIN, Sean Christopher | Amministratore | Yew Trees, Main Street North Aberford LS25 3AA West Yorkshire | England | British | Director | 166903410002 | ||||
RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 91993060004 | |||||||
BARKER, James Alan | Segretario | 20 Crabtree Park GL7 4LT Fairford Gloucestershire | British | 31113100001 | ||||||
COOPER, David Lawrence | Segretario | 29 Mercot Close Oakenshaw South B98 7YX Redditch Worcestershire | British | Financial Director | 29904260001 | |||||
DARLINGTON, Stephen Jeffrey | Segretario | Ty Gwyn Mentone Avenue Aspley Guise MK17 8EQ Milton Keynes Bedfordshire | British | Director | 43547190001 | |||||
HEWINS, Percy | Segretario | 19 Lion Street DY8 1UE Stourbridge West Midlands | British | 4262210001 | ||||||
ROGERS, Kevin Alan | Segretario | New Homage Cottage 31 Brewood Road Coven WV9 5BY Wolverhampton Staffordshire | British | Company Director | 39430340001 | |||||
SHAKESPEARE, Ann | Segretario | 56 Ingatestone Drive Wordsley DY8 5PT Stourbridge West Midlands | British | Director | 21552870002 | |||||
WARD, Elizabeth Anne | Segretario | 23 Chapel Road Earith PE17 3PU Huntingdon Cambridgeshire | British | 32157210001 | ||||||
BARKER, James Alan | Amministratore | 20 Crabtree Park GL7 4LT Fairford Gloucestershire | British | Finance Director | 31113100001 | |||||
BARRETT, Barrie Michael | Amministratore | The Firs Spetchley Road WR5 2NL Worcester Worcestershire | British | Director | 4061200002 | |||||
BLACKBURN, Peter Edward | Amministratore | 20 Church Lane Downend BS16 6TB Bristol Avon | British | Director | 5531260001 | |||||
BREALEY, Graham Michael | Amministratore | 17 The Paddock Eaton Ford St Neots PE19 3SA Huntingdon Cambridgeshire | England | British | Company Director | 61631390001 | ||||
COOPER, David Lawrence | Amministratore | 29 Mercot Close Oakenshaw South B98 7YX Redditch Worcestershire | British | Financial Director | 29904260001 | |||||
DARLINGTON, Stephen Jeffrey | Amministratore | Ty Gwyn Mentone Avenue Aspley Guise MK17 8EQ Milton Keynes Bedfordshire | British | Director | 43547190001 | |||||
ERRINGTON, David John | Amministratore | Foxstone House Fieldways GL6 0DY Nailsworth Gloucestershire | British | Chartered Accountant | 83154330001 | |||||
HEWINS, Percy | Amministratore | 19 Lion Street DY8 1UE Stourbridge West Midlands | British | Director | 4262210001 | |||||
HEWLETT, David | Amministratore | Roseland 22 Aylsham Road NR11 6TE Tuttington Norfolk | England | British | Company Director | 87102720001 | ||||
JOHNSON, Ronald James | Amministratore | 12 Summer Road Rowley Regis B65 9QQ Warley West Midlands | British | Director | 21552860001 | |||||
MCARTHUR, Alexander Nigel | Amministratore | 39 Cornhill EC3V 3NU London | British | Chartered Accountant | 1571200002 | |||||
NELMES CROCKER, Michael | Amministratore | Chartleys Box GL6 9HR Minchinhampton Stroud Gloucestershire | British | Company Director | 1729130003 | |||||
ROGERS, Kevin Alan | Amministratore | New Homage Cottage 31 Brewood Road Coven WV9 5BY Wolverhampton Staffordshire | British | Company Director | 39430340001 | |||||
SAMUEL, John William Young Strachan | Amministratore | Main Street North Aberford LS25 3AA Leeds Yew Trees | England | British | Chartered Accountant | 3909060002 | ||||
SELLARS, Paul | Amministratore | White House Withyham TN7 4BT Hartfield East Sussex | England | British | Finance Director | 50761250001 | ||||
SHAKESPEARE, Ann | Amministratore | 56 Ingatestone Drive Wordsley DY8 5PT Stourbridge West Midlands | British | Director | 21552870002 | |||||
TROMANS, James | Amministratore | 14 Moat Road B68 8EB Oldbury West Midlands | British | Director | 59715450001 | |||||
TWELLS, Paul Stephen | Amministratore | 158 Ingram Road NG6 9GQ Bulwell Nottingham | British | Company Director | 51937070001 | |||||
MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED | Amministratore | 39 Cornhill EC3V 3NU London | 41291250009 |
00118632 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 15 ago 1997 Consegnato il 02 set 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 15 nov 1995 Consegnato il 21 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 05 nov 1993 Consegnato il 18 nov 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a unit 5 bala industrial estate bala gwynedd t/no: wa 644562 and the proceeds of sale and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 10 giu 1985 Consegnato il 10 giu 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0