00118632 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società00118632 LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00118632
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 00118632 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova 00118632 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 00118632 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BODDIS (OLD HILL) LIMITED17 nov 191117 nov 1911

    Quali sono gli ultimi bilanci di 00118632 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2012
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2013
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per 00118632 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 ott 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 ott 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 00118632 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per 00118632 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Mr Sean Christopher Wyndham-Quin come amministratore in data 15 dic 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John William Young Strachan Samuel come amministratore in data 17 dic 2017

    1 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed bb engineering\certificate issued on 13/07/16
    pagineCERTNM

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Delete share cap restrictions 31/05/2013
    RES13
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mag 2013

    • Capitale: GBP 3,688,749
    5 pagineSH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di John William Young Strachan Samuel come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2007

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di 00118632 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    WYNDHAM-QUIN, Sean Christopher
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    EnglandBritishDirector166903410002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Segretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    COOPER, David Lawrence
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    BritishFinancial Director29904260001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Segretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    BritishDirector43547190001
    HEWINS, Percy
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    British4262210001
    ROGERS, Kevin Alan
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    Segretario
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    BritishCompany Director39430340001
    SHAKESPEARE, Ann
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector21552870002
    WARD, Elizabeth Anne
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British32157210001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    BritishFinance Director31113100001
    BARRETT, Barrie Michael
    The Firs
    Spetchley Road
    WR5 2NL Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Firs
    Spetchley Road
    WR5 2NL Worcester
    Worcestershire
    BritishDirector4061200002
    BLACKBURN, Peter Edward
    20 Church Lane
    Downend
    BS16 6TB Bristol
    Avon
    Amministratore
    20 Church Lane
    Downend
    BS16 6TB Bristol
    Avon
    BritishDirector5531260001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director61631390001
    COOPER, David Lawrence
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    BritishFinancial Director29904260001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Amministratore
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    BritishDirector43547190001
    ERRINGTON, David John
    Foxstone House
    Fieldways
    GL6 0DY Nailsworth
    Gloucestershire
    Amministratore
    Foxstone House
    Fieldways
    GL6 0DY Nailsworth
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant83154330001
    HEWINS, Percy
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector4262210001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Amministratore
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director87102720001
    JOHNSON, Ronald James
    12 Summer Road
    Rowley Regis
    B65 9QQ Warley
    West Midlands
    Amministratore
    12 Summer Road
    Rowley Regis
    B65 9QQ Warley
    West Midlands
    BritishDirector21552860001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    BritishChartered Accountant1571200002
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director1729130003
    ROGERS, Kevin Alan
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    Amministratore
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    BritishCompany Director39430340001
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Amministratore
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritishChartered Accountant3909060002
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritishFinance Director50761250001
    SHAKESPEARE, Ann
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector21552870002
    TROMANS, James
    14 Moat Road
    B68 8EB Oldbury
    West Midlands
    Amministratore
    14 Moat Road
    B68 8EB Oldbury
    West Midlands
    BritishDirector59715450001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Amministratore
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    BritishCompany Director51937070001
    MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    41291250009

    00118632 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 02 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 5 bala industrial estate bala gwynedd t/no: wa 644562 and the proceeds of sale and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 giu 1985
    Consegnato il 10 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0