Stephen Jeffrey DARLINGTON
  • Dati
  • Gran Bretagna
  • Aziende
  • Cerca aziende
  • Sanzioni
  • Cerca sanzioni
  • Stephen Jeffrey DARLINGTON

    Persona fisica

    TitoloMr
    NomeStephen
    Secondo nomeJeffrey
    CognomeDARLINGTON
    Data di nascita
    È un dirigente societarioNo
    Incarichi
    Attivo0
    Inattivo5
    Dimesso55
    Totale60

    Incarichi

    Incarichi assegnati
    Nominato aData di nominaData di dimissioniStato della societàProfessioneRuoloIndirizzoPaese di residenzaNazionalità
    PEC (LIVERPOOL) LIMITED04 apr 2000ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    PALATINE ENGRAVING PENSION TRUSTEES LIMITED04 apr 2000ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    PEC (LIVERPOOL) LIMITED05 ott 1998ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    PEC (SCOTLAND) LIMITED05 ott 1998ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    PALATINE ENGRAVING PENSION TRUSTEES LIMITED05 ott 1998ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS CONVERTING (UK HOLDINGS) LIMITED30 set 201021 nov 2022ScioltaChairmanAmministratore
    Woburn Road Industrial Estate, Wolseley Road
    Kempston
    MK42 7XT Bedford
    C/O Atlas Converting Equipment Limited
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish
    ATLAS CONVERTING EQUIPMENT LIMITED25 ott 201030 nov 2020AttivaChairmanAmministratore
    Wolseley Road
    Kempston
    MK42 7XT Bedford
    United KingdomBritish
    BOBST UK & IRELAND LTD19 mag 200831 lug 2010AttivaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD19 mag 200831 lug 2010ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST UK & IRELAND LTD29 feb 200831 lug 2010AttivaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD29 feb 200831 lug 2010ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    BOBST UK HOLDINGS LTD21 lug 199831 lug 2010AttivaSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST UK HOLDINGS LTD01 giu 199831 lug 2010AttivaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    BOBST UK & IRELAND LTD01 giu 199930 apr 2006AttivaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD21 lug 199830 apr 2006ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    LASERCOMB DIES LIMITED25 giu 199831 gen 2006AttivaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS HURLEY-MOATE LIMITED30 gen 200430 giu 2005ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    ATLAS HURLEY-MOATE LIMITED30 gen 200430 giu 2005ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS GROUP AMERICAS LIMITED30 gen 200430 giu 2005ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    TITAN CONVERTING EQUIPMENT LIMITED30 gen 200430 giu 2005ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    ATLAS CONVERTING EQUIPMENT LIMITED30 gen 200430 giu 2005AttivaSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    ATLAS GROUP AMERICAS LIMITED30 gen 200430 giu 2005ScioltaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    TITAN CONVERTING EQUIPMENT LIMITED30 gen 200430 giu 2005ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST MANCHESTER LTD30 gen 200430 giu 2005AttivaSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST UK & IRELAND LTD01 giu 199930 giu 2005AttivaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    OSCAR FRIEDHEIM LIMITED01 giu 199930 giu 2005AttivaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    FRIEDHEIM INTERNATIONAL LIMITED19 ott 199830 giu 2005AttivaAccountantAmministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritish
    PEC (SCOTLAND) LIMITED04 apr 200023 set 2003ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    BOBST IRELAND (SERVICE) LTD04 apr 200023 apr 2003ScioltaAccountantSegretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    British
    SWEMKO LONDON LIMITED21 lug 199819 mar 2001ScioltaAccountantAmministratore
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    OSCAR FRIEDHEIM LIMITED01 giu 199904 apr 2000AttivaAccountantSegretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    LASERCOMB DIES LIMITED25 giu 199804 apr 2000AttivaAccountantSegretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    BB & EA LIMITED26 lug 199618 ago 1997ScioltaSegretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    CONTRACTORS' SCAFFOLDING AND FORMWORK LIMITED12 lug 199618 ago 1997ScioltaSegretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British
    00118632 LIMITED12 lug 199618 ago 1997AttivaDirectorAmministratore
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0