FREEMAN GROUP LIMITED

FREEMAN GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFREEMAN GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00568797
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FREEMAN GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FREEMAN GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Adsetts House 16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FREEMAN GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FREEMAN GROUP PLC21 mar 198821 mar 1988
    FREEMAN GROUP LIMITED(THE)01 mar 198201 mar 1982
    T R FREEMAN LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    T.R.FREEMAN AND SON(CAMBRIDGE)LIMITED11 lug 195611 lug 1956

    Quali sono gli ultimi bilanci di FREEMAN GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per FREEMAN GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di Sig Plc come persona con controllo significativo il 17 mag 2021

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kulbinder Kaur Dosanjh come segretario in data 31 mar 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andrew Watkins come amministratore in data 31 mar 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kulbinder Kaur Dosanjh come amministratore in data 31 mar 2021

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Kulbinder Kaur Dosanjh il 22 dic 2020

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 nov 2020

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 28/10/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard Charles Monro come amministratore in data 18 ott 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Kulbinder Kaur Dosanjh come amministratore in data 18 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Charles Monro come segretario in data 18 ott 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Kulbinder Kaur Dosanjh come segretario in data 18 ott 2019

    2 pagineAP03

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Charles Monro il 29 giu 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Richard Charles Monro il 29 giu 2018

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Jackson il 29 giu 2018

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di FREEMAN GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish186473820002
    WATKINS, Andrew
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritish281612300001
    BEST, John David
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    British2810080001
    BOW, Christopher John
    3 Sternes Way
    CB2 5DA Stapleford
    Cambridgeshire
    Segretario
    3 Sternes Way
    CB2 5DA Stapleford
    Cambridgeshire
    British9235350001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Segretario
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    264254780001
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Segretario
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    British59480370001
    SWYNNERTON, John Ralph
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    30 Bents Road
    S11 9RJ Sheffield
    South Yorkshire
    British2646260001
    BEST, John David
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Milbanke 43 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish2810080001
    CHOMBARD DE LAUWE, Francois
    6 Placesaint Germain Des Pres
    FOREIGN 75006 Paris
    France
    Amministratore
    6 Placesaint Germain Des Pres
    FOREIGN 75006 Paris
    France
    French27956080001
    DAVIES, Gareth Wyn
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Amministratore
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish109674760001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Amministratore
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish231199720003
    ENGLISH, Euan Christopher
    Wensum Farm
    Elsing
    Dereham
    Norfolk
    Amministratore
    Wensum Farm
    Elsing
    Dereham
    Norfolk
    British6660410001
    FORRESTER, William Wilson
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Coombs Hay
    16 Burre Close
    DE45 1GD Bakewell
    Derbyshire
    EnglandBritish27743040001
    HORNBY, John Martin
    The Owl House Vicarage Hill
    TN16 1AY Westerham
    Kent
    Amministratore
    The Owl House Vicarage Hill
    TN16 1AY Westerham
    Kent
    British46845290001
    MCRITCHIE PRATT, Christopher Lucan
    Brackendale
    Shelford Bottom Babraham Road
    CB2 4AY Cambridge
    Amministratore
    Brackendale
    Shelford Bottom Babraham Road
    CB2 4AY Cambridge
    British37293570001
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritish59480370001
    POTTER, James Gerrard
    42 High Street
    Balsham
    CB1 6EP Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    42 High Street
    Balsham
    CB1 6EP Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish9095020001
    PRUST, Francis Charles
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    Amministratore
    Peverill
    25 Wharfe Bank
    LS22 5JP Collingham
    West Yorkshire
    British54280001
    ROE, Darren
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Amministratore
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritish106708580001
    WARREN, William Russell
    Scrumbles Dibden Hill
    HP8 4RD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Scrumbles Dibden Hill
    HP8 4RD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British9235360004
    WILLIAMS, David
    48 Wood Lane
    Wickersley
    S66 1JX Rotherham
    "Merrymede"
    South Yorkshire
    Amministratore
    48 Wood Lane
    Wickersley
    S66 1JX Rotherham
    "Merrymede"
    South Yorkshire
    EnglandEnglish127986830001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FREEMAN GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00998314
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FREEMAN GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 08 ott 1992
    Consegnato il 15 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of london road stapleford cambridge cambridgeshire t/n CB88436.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 03 feb 1992
    Consegnato il 19 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 20 th december 1991
    Brevi particolari
    By way of assignment all its present and future rights title and interest in and to the principal debt and the benefit of the sale agreement, assignments of contracts and tax and all other securities. By way of first fixed charge all the property comprised in the assignments of contracts and tax (see 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 feb 1992
    Consegnato il 18 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M629C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 mar 1985
    Consegnato il 22 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 28 apr 1982
    Consegnato il 12 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the eothercompanies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Charted by the principal deed & further deed.. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 18 set 1981
    Consegnato il 29 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein
    Brevi particolari
    Charged by the principal deed & further deed.. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 set 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 19 gen 1981
    Consegnato il 03 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all of any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Transazioni
    • 03 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 giu 1979
    Consegnato il 25 giu 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Together with all buildings & fixturs & fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 apr 1977
    Consegnato il 02 mag 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts. Uncalled capital with all buildings, fixtures fixed plant & machinery fixed & floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 07 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0