EXSIMPIL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXSIMPIL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00640930
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXSIMPIL LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova EXSIMPIL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXSIMPIL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIMPLEX PILING LIMITED30 ott 195930 ott 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXSIMPIL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EXSIMPIL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 14 mag 2013

    • Capitale: GBP 88,247
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Nomina di John William Young Strachan Samuel come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di EXSIMPIL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Amministratore
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARD, Paul William
    6 Hampden Close
    North Weald
    CM16 6JX Epping
    Essex
    Segretario
    6 Hampden Close
    North Weald
    CM16 6JX Epping
    Essex
    British74177720001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Segretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BAKER, Anthony Charles
    30 Wilkinson Close
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    30 Wilkinson Close
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    British20808860001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BISHOP, Michael John
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British11164490003
    BOLSHER, Terence
    The Hop House
    Fields Courtyard
    DN22 Grove Retford
    Notts
    Amministratore
    The Hop House
    Fields Courtyard
    DN22 Grove Retford
    Notts
    British10374150001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish61631390001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Amministratore
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Amministratore
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Amministratore
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritish87102720001
    HOLROYD, Thomas Harry
    James House 1 Jacks Lane
    Marchington
    ST14 8LW Uttoxeter
    Staffordshire
    Amministratore
    James House 1 Jacks Lane
    Marchington
    ST14 8LW Uttoxeter
    Staffordshire
    British36692470001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    British1729130003
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    SMITH, Steven David
    10 Woodgate Close
    Charlton Kings
    GL52 6UW Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    10 Woodgate Close
    Charlton Kings
    GL52 6UW Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish65590120001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Amministratore
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    British51937070001
    WILKINS, Alan John
    11 Blacksmith Drive Grove Green
    Weavering
    ME14 5SZ Maidstone
    Kent
    Amministratore
    11 Blacksmith Drive Grove Green
    Weavering
    ME14 5SZ Maidstone
    Kent
    British3052320001
    WOOLFE, Jonathan Michael David
    98 Deepwell Avenue
    Halfway
    S20 4ST Sheffield
    Amministratore
    98 Deepwell Avenue
    Halfway
    S20 4ST Sheffield
    British62130320001

    EXSIMPIL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 18 dic 1998
    Consegnato il 21 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £274,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Brevi particolari
    New junttan PM20LC piling rig s/no.1189.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 01 dic 1998
    Consegnato il 04 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    On casagrande B150E piling rig-serial no.c/103063-00 with concrete pumping system and all other component parts,accessories,improvements and renewals.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 04 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 02 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property land on the south side of garage lane setchley norfolk title no NY91815 and the proceeds of sale tog with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0