BB KONSTRUCTION LIMITED

BB KONSTRUCTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBB KONSTRUCTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00713070
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BB KONSTRUCTION LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova BB KONSTRUCTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BB KONSTRUCTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KASS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED17 gen 196217 gen 1962

    Quali sono gli ultimi bilanci di BB KONSTRUCTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BB KONSTRUCTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 14 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Nomina di John William Young Strachan Samuel come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BB KONSTRUCTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Amministratore
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Segretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    CODLING, Barry
    The Manse
    Carr Road
    DN39 6TX Ulceby
    South Humberside
    Segretario
    The Manse
    Carr Road
    DN39 6TX Ulceby
    South Humberside
    British68814380001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Segretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    MCDONOUGH, Paul, Director
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    Segretario
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    British9561800001
    SYDNEY, Barry Sidney
    The Manse
    Carr Road
    Ulceby
    South Humberside
    Segretario
    The Manse
    Carr Road
    Ulceby
    South Humberside
    British37780110001
    WARD, Elizabeth Anne
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British32157210001
    WILD, Martin Alastair
    Ravenshaw Barn Eldroth
    Austwick
    LA2 8AL Lancaster
    Segretario
    Ravenshaw Barn Eldroth
    Austwick
    LA2 8AL Lancaster
    British36979030002
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish61631390001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Amministratore
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritish87102720001
    MARSHALL, Richard John
    126 Grimsby Road
    Humberston
    DN36 4AH Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    126 Grimsby Road
    Humberston
    DN36 4AH Grimsby
    South Humberside
    EnglandBritish22970740001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    MCCABE, David Mun Ro
    104 Doncaster Road
    DN15 7DJ Scunthorpe
    South Humberside
    Amministratore
    104 Doncaster Road
    DN15 7DJ Scunthorpe
    South Humberside
    British4793550001
    MCDONOUGH, Paul, Director
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    Amministratore
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    United KingdomBritish9561800001
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    British1729130003
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Amministratore
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    British51937070001
    MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    41291250009

    BB KONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 02 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 mar 1981
    Consegnato il 23 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £37,000 with further advances and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land off cliff drive burton on stather near scunthorpe humberside.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Building Society.
    Transazioni
    • 23 mar 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1980
    Consegnato il 06 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at crowlees road, mirfield, W.yorks. Title no. Wyk 32212 together with all fixtures whatsoever now or at any that hherafter affixed of attached to the property or any part hereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Limited.
    Transazioni
    • 06 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 17 mar 1980
    Consegnato il 19 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £94,000 al othe rmonies due or to become due from the company to the charge on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/Hold land at summer hill, west park grove, leeds, west yorkshire together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Buildings Society
    Transazioni
    • 19 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1979
    Consegnato il 16 mag 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £45,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H 2.951 acres of land at winchester drive/stonyhurst close, bottes forrd, nr scunthorpe humberside.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Building Society
    Transazioni
    • 16 mag 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 18 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0