EXBIRCO 1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXBIRCO 1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00788201
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXBIRCO 1 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EXBIRCO 1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXBIRCO 1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIRCHWOOD CONCRETE PRODUCTS LIMITED16 gen 196416 gen 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXBIRCO 1 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2012
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2013
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EXBIRCO 1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 14 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    6 pagineAA

    Nomina di John William Young Strachan Samuel come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di EXBIRCO 1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Amministratore
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritishChartered Accountant3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Segretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    WADE, Barry Anthony
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    British150120001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    BritishFinance Director31113100001
    BISHOP, Michael John
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Britannia House
    Staverton Technology Park
    GL51 6TQ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director11164490003
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director61631390001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Amministratore
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    BritishAccountant43547190001
    DENMAN, Charles Edward
    97 Jubilee Close
    Melbourne
    DE73 8GR Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    97 Jubilee Close
    Melbourne
    DE73 8GR Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director102694530001
    FEENAN, Gerard
    191 Upton Road
    CH43 7QF Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    191 Upton Road
    CH43 7QF Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritishSales And Marketing Director122236830001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Amministratore
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director87102720001
    LEE, Thomas Joseph
    Briardene Brancepeth Chare
    SR8 1LU Peterlee
    Durham
    Amministratore
    Briardene Brancepeth Chare
    SR8 1LU Peterlee
    Durham
    BritishCompany Director54828280001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    BritishChartered Accountant1571200002
    MOORE, Patrick John
    5 Old Hall Gardens
    Coddington
    NG24 2QJ Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    5 Old Hall Gardens
    Coddington
    NG24 2QJ Newark
    Nottinghamshire
    BritishSales And Marketing Director23123380001
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director1729130003
    NUTTER, John Raymond
    Croft Cottage
    2 Mill Lane Hartington
    SK17 0AN Buxton
    Derbyshire
    Amministratore
    Croft Cottage
    2 Mill Lane Hartington
    SK17 0AN Buxton
    Derbyshire
    BritishCivil Engineer39743500001
    REDDISH, Graham William
    11 Longedge Grove
    Wingerworth
    S42 6NU Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    11 Longedge Grove
    Wingerworth
    S42 6NU Chesterfield
    Derbyshire
    BritishEngineer23123390001
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritishFinance Director50761250001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Amministratore
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    BritishCompany Director51937070001
    WADE, Barry Anthony
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    161 Palmerston Street
    Westwood
    NG16 5HZ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishAccountant150120001

    EXBIRCO 1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 lug 2000
    Consegnato il 27 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The chargor covenanted that it will demand in writing made to it by the security trustee pay or discharge to the security trustee all money and liabilities at the debenture date or in the future due owing or incurred to each beneficiary as and when the same falls due for payment by the chargor
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 dic 1999
    Consegnato il 21 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Various chattels under agreement number 258-092222-17. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 02 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 26 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at birchwood way cotes park industrial estate somercotes derbyshire t/n dy 234794 and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at (pye bridge industrial estate somercotes) sub-station lying south of lower somercotes (pye bridge industrial estate somercotes)derbyshiret/n dy 233710 and/or the proceeds of sale and assigns goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 lug 1977
    Consegnato il 03 ago 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000-
    Brevi particolari
    Land at somercotes, derbyshire together with plant and machinery (see schedule attached to doc M42 for further details).
    Persone aventi diritto
    • J.L. Kiert Co. LTD.
    Transazioni
    • 03 ago 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0