INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED

INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00817650
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP PLC02 gen 200202 gen 2002
    JACKSON GROUP PLC28 ago 196428 ago 1964

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 dic 2017

    • Capitale: GBP 1.0
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Franco Martinelli come amministratore in data 06 dic 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James William Borrett il 11 gen 2017

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Nicholas James William Borrett come amministratore in data 31 ago 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Lloyd Rogers come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Iain Stuart Urquhart il 23 ago 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2016

    Stato del capitale al 26 mag 2016

    • Capitale: GBP 2,147,108
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2015

    Stato del capitale al 26 mag 2015

    • Capitale: GBP 2,147,108
    SH01

    Nomina di Iain Stuart Urquhart come amministratore in data 17 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Tame come amministratore in data 17 dic 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2014

    Stato del capitale al 27 mag 2014

    • Capitale: GBP 2,147,108
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Nicholas Borrett come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BABCOCK CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3133134
    173822100001
    BORRETT, Nicholas James William
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish171010990001
    URQUHART, Iain Stuart
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    EnglandScottish104722420003
    BILLIALD, Stanley Alan Royall
    Hyde Cottage
    Hyde Lane Churt
    GU10 2LP Farnham
    Surrey
    Segretario
    Hyde Cottage
    Hyde Lane Churt
    GU10 2LP Farnham
    Surrey
    Other35839210001
    BORRETT, Nicholas James William
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    171249740001
    BORRETT, Nicholas James William
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    171271240001
    PALMER, Peter Edward
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    British21105820001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    Segretario
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    British52221890002
    PRATT, Cyril Harry
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    British8832470001
    TELLER, Valerie Francine Anne
    Pinemartin Close
    NW2 6YY London
    17 Badger Court
    Segretario
    Pinemartin Close
    NW2 6YY London
    17 Badger Court
    British139336240001
    WOOLLHEAD, John Andrew
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    Segretario
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    British13072060002
    ANDREWS, Peter John
    Church Farm Church Lane
    Earl Soham
    IP13 7SD Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Church Farm Church Lane
    Earl Soham
    IP13 7SD Woodbridge
    Suffolk
    British10441500003
    BARNETT, Rick
    67 Andover Road
    RG14 6JE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    67 Andover Road
    RG14 6JE Newbury
    Berkshire
    British89937880001
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish47892490001
    BLAKE, Martin Graham
    23 Winston Avenue
    IP4 3LS Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    23 Winston Avenue
    IP4 3LS Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish85938450002
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish4250980001
    BRIERLEY, Philip
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    British54808010001
    BURKE, David Peter
    12 Dunvegan Way
    MK41 8PE Bedford
    Amministratore
    12 Dunvegan Way
    MK41 8PE Bedford
    British86390110001
    CHILTON, Albert Edmund
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    Amministratore
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    British6236180002
    CLARKE, Bernard Francis
    Tasina
    28 The Avenue
    IP1 3TD Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Tasina
    28 The Avenue
    IP1 3TD Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish69383800001
    FOSTER, Simon
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    British94152980001
    FRYER, Peter Kenneth
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Other79955580001
    GREEN, Peter Anthony
    Seagull Cottage
    Undercliff Road East
    IP11 7LU Felixstowe
    Suffolk
    Amministratore
    Seagull Cottage
    Undercliff Road East
    IP11 7LU Felixstowe
    Suffolk
    British17500270001
    HODGKINSON, Michael
    19 Turner Gardens
    IP12 4JD Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    19 Turner Gardens
    IP12 4JD Woodbridge
    Suffolk
    British82129590001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JACKSON, Frank
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    British10015550001
    KENDRICK, Michael John
    44 Edgemont Road
    Weston Favell
    NN3 3PQ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    44 Edgemont Road
    Weston Favell
    NN3 3PQ Northampton
    Northamptonshire
    British15169410001
    MACHELL, Eric Ernest
    19 Heathyfields Road
    GU9 0BW Farnham
    Surrey
    Amministratore
    19 Heathyfields Road
    GU9 0BW Farnham
    Surrey
    British32179980001
    MARTINELLI, Franco
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish85507440001
    NEALL, Richard William
    3 Fulchers Field
    IP13 9HT Framlington
    Suffolk
    Amministratore
    3 Fulchers Field
    IP13 9HT Framlington
    Suffolk
    Australian76713310001
    O'KANE, John Peter
    Holly Cottage
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Holly Cottage
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish106172200001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    Amministratore
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    British52221890002
    ROBERTSON, Alan Robert
    Foss Dyke Farm
    Red House Lane Moor Monkton
    Y026 8JG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Foss Dyke Farm
    Red House Lane Moor Monkton
    Y026 8JG York
    North Yorkshire
    British63758950006
    ROGERS, Peter Lloyd
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    Amministratore
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    C/O Babcock International Group Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish49805580003
    STANTON, Derek William
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    British10425830001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1517100
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    INTEGRATED SAFETY SERVICES GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and trust debenture
    Creato il 07 ott 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any of them to the trustee and or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1999
    Consegnato il 24 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as land on south west side of dodds lane kesgrave ipswich; t/no SK155939. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the sites of 2, 4 and 6 fishergate and 1 to 6 percy place nottingham t/n NT59159. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 115 burrell road ipswich t/n SYK124923. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 199/201 mill cross lane norwich t/n NK21866. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings on the west side of mansion close northampton t/n NN67379. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 5, 6 and 8 maltings crown place woodbridge t/n SK27754. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 18 mar 1998
    Consegnato il 21 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land off bramford lane ipswich t/no.SK137141. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 ago 1997
    Consegnato il 22 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 1 dobbs drift kesgrave ipswich suffolk.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 07 feb 1996
    Consegnato il 12 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charges over offices and yard at dobbs drift kesgrave suffolk, 2-6 fishergate nottingham nottinghamshire t/no. NT59159, 5,6,8 crown place woodbridge suffolk t/no.sk 27754 and 12 other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 nov 1995
    Consegnato il 09 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-parcel of land being the site of the property previously k/a 83 dobbs lane kesgrave ipswich sufolk. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set off
    Creato il 07 feb 1983
    Consegnato il 18 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or A.T.C. pheumatics LTD to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 mar 1969
    Consegnato il 06 mar 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) the properties mentioned in the schedule all fixtures fixed plant and machinery. 2) all other f/h and l/h property all fixtures, fixed plant and machinery. 3) goodwill and uncalled capital 4) undertaking and all other property and assets of the company. (1) (2) & (3) described as fixed first charge and (4) described as a floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank LTD
    Transazioni
    • 06 mar 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0