Lorraine Grace BEAVIS
Persona fisica
Titolo | |
---|---|
Nome | Lorraine |
Secondo nome | Grace |
Cognome | BEAVIS |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 3 |
Dimesso | 47 |
Totale | 50 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEKO LIMITED | 01 gen 2007 | Sciolta | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | |||
INVERCON PAPERMILLS LIMITED | 01 gen 2007 | Sciolta | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | |||
JAMONT UK LIMITED | 01 gen 2007 | Sciolta | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | |||
BRITISH TISSUES LIMITED | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Attiva | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach Horwich BL6 6SY Bolton Lancashire | British | ||
STUART EDGAR | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Attiva | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | ||
FORT STERLING LIMITED | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Attiva | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | ||
STUART EDGAR | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Attiva | Company Secretary | Amministratore | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | England | British |
GEORGIA-PACIFIC GB LIMITED | 18 dic 2006 | 29 lug 2011 | Attiva | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | ||
GEORGIA-PACIFIC GROUP SERVICES LIMITED | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Sciolta | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach Horwich BL6 6SY Bolton Lancashire | British | ||
HARMON INTERNATIONAL LIMITED | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Sciolta | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | ||
GEORGIA-PACIFIC INTERNATIONAL LIMITED | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Sciolta | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | ||
FORT JAMES UK LIMITED | 01 gen 2007 | 29 lug 2011 | Sciolta | Segretario | Stadium House 2 Eastgate Approach BL6 6SY Horwich Bolton Lancashire | British | ||
BRAINTREE OFFICE VILLAGE MANAGEMENT LIMITED | 20 set 2004 | 02 ott 2006 | Attiva | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
PROPENCITY LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | Attiva | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
JACKSON PROPERTIES II LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | Attiva | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG CONSTRUCTION LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | In amministrazione | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG JACKSON LIMITED | 01 apr 1997 | 02 ott 2006 | In amministrazione | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG HARRY NEAL LIMITED | 03 giu 2004 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG UK LIMITED | 30 mar 2004 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG RETAIL AND LEISURE HOLDINGS LIMITED | 01 ago 2002 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG INTERIOR LIMITED | 01 ago 2002 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG DEVELOPMENTS LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
TOTTY LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG TOTTY BUILDING LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG NORTHERN LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG JACKSON SPECIAL PROJECTS LIMITED | 01 apr 1997 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED | 01 apr 1997 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
JACKSON CONSTRUCTION LIMITED | 01 apr 1997 | 02 ott 2006 | Sciolta | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
INTERIOR SERVICES GROUP LIMITED | 20 nov 2002 | 02 ott 2006 | Liquidazione | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
ISG RETAIL AND LEISURE LIMITED | 01 ago 2002 | 02 ott 2006 | Liquidazione | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
TOTTY DEVELOPMENTS LIMITED | 13 mag 2002 | 02 ott 2006 | Liquidazione | Segretario | 2 Huntington Crescent Headingley LS16 5RT Leeds | British | ||
RED HALL COURT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15 lug 2002 | 12 mag 2003 | Attiva | Facilities Manager | Segretario | 2 Red Hall Court IP11 7AQ Felixstowe Suffolk | British | |
FACTAIR LIMITED | 01 apr 1997 | 03 gen 2003 | Attiva | Segretario | 2 Red Hall Court IP11 7AQ Felixstowe Suffolk | British | ||
PROACTIVE MANUFACTURING LIMITED | 13 mag 2002 | 03 gen 2003 | Sciolta | Segretario | 2 Red Hall Court IP11 7AQ Felixstowe Suffolk | British | ||
GAYCRETE LIMITED | 08 dic 1999 | 03 gen 2003 | Sciolta | Chartered Secretary | Amministratore | 2 Red Hall Court IP11 7AQ Felixstowe Suffolk | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0