SOMERFIELD GROUP LIMITED

SOMERFIELD GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOMERFIELD GROUP LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 00833416
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GATEWAY STORES LIMITED06 gen 196506 gen 1965

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al04 gen 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il04 ott 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso

    pagineCERTIPS

    Varie

    Forms band z -conversion to I &ps
    pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to I & ps 05/10/2010
    RES13

    Nomina di Mr Stephen Parry come segretario

    pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 set 2010

    Stato del capitale al 29 set 2010

    • Capitale: GBP 120,040,300
    SH01

    Bilancio modificato redatto al 02 gen 2010

    pagineAAMD

    Bilancio redatto al 02 gen 2010

    pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Humes il 01 ago 2010

    pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Hurrell il 01 ago 2010

    pagineCH01

    Bilancio redatto al 02 mag 2009

    pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 27 apr 2010 al 04 gen 2010

    pagineAA01

    Dimissioni del revisore

    pagineAUD

    Indirizzo della sede legale modificato da Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ in data 20 nov 2009

    pagineAD01

    Cessazione della carica di William Robson come amministratore

    pagineTM01

    Cessazione della carica di Emily Martin come segretario

    pagineTM02

    Nomina di Mrs Caroline Jane Sellers come segretario

    pagineAP03

    legacy

    pagine363a

    legacy

    pagine403a

    legacy

    pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re documents 17/03/2009
    RES13

    legacy

    pagine288a

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine288a

    Chi sono gli amministratori di SOMERFIELD GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Segretario
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154610860001
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    146966510001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishFinance Director84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritishGeneral Manager - Food Group99724260001
    BROWN, Michael Alfred
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Windrush Great Billing Park
    NN3 9BL Northampton
    Northamptonshire
    British50692920001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Segretario
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Segretario
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Segretario
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    BritishCompany Secretary115285710001
    ASHTON, Yvonne Margaret
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    Amministratore
    1 West Dene
    Stoke Bishop
    BS9 2BQ Bristol
    Avon
    BritishChartered Accountant45225070002
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Amministratore
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritishFinance Director85825120001
    BICKERSTAFFE, Katie
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    Amministratore
    Aston Lodge
    5 Highdale Road
    BS21 7UW Clevedon
    Avon
    BritishCompany Director110621690001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritishCompany Director74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Amministratore
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    BritishRetail Director111624590001
    COATES, Philip Raymond
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    Amministratore
    2 Berestede Road
    W6 9NP London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60114990002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    Amministratore
    Crossways House Old Coach Road
    Cross
    BS26 2EL Axbridge
    Somerset
    BritishCost & Management Accountant59071930001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Amministratore
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary20888800002
    HARTE, Damien Bernard
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    Amministratore
    13 Cambridge Park
    Redland
    BS6 6XW Bristol
    BritishCertified Accountant33922420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    BritishDirector91828160003
    MASON, Paul
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    Burley Woodhead
    LS29 7SW Ilkley
    Moorlands
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141310720001
    MITCHELL INNES, Alistair Campbell
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Langton Lodge Station Road
    Sunningdale
    SL5 0QR Ascot
    Berkshire
    BritishChief Executive1386650001
    NELLIST, Robert Henry Harger
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Spooners 28 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JB St Albans
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant5435750001
    OAKES, Martin Nicholas
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Oakhurst House
    Fulready, Ettington
    CV37 7PE Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishLogistics Director86206380002
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Amministratore
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    BritishChartered Accountant777200001
    SMITH, Alan Frank
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    Brambledown Grove Farm
    Droitwich Road Feckenham
    B96 6JA Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector46000100003
    SMITH, Colin George
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Tallius
    Jubilee Road, Finchampstead
    RG40 3SR Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector111628890001
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Amministratore
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    BritishCompany Director61599510002

    SOMERFIELD GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 06 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any rcf creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A target group debenture
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 28 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any senior creditor and any pik creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 28 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 ott 1989
    Consegnato il 31 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For full details see certificate
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • S. G. Warburg & Co Ltdas Agent and Trustee for Itself and for Each Lender (As Defined Therein)
    Transazioni
    • 31 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0