MARSDENS PHARMACY LIMITED
Panoramica
Nome della società | MARSDENS PHARMACY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00888978 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MARSDENS PHARMACY LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MARSDENS PHARMACY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2 Peterwood Way CR0 4UQ Croydon Surrey England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MARSDENS PHARMACY LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MILLS CHEMIST (B.C.) LIMITED | 30 apr 1999 | 30 apr 1999 |
C.J. CLARKE (CHEMISTS) LIMITED | 04 ott 1966 | 04 ott 1966 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MARSDENS PHARMACY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per MARSDENS PHARMACY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 mar 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kirit Chimanbhai Patel come amministratore in data 16 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lion House Red Lion Street London WC1R 4GB a 2 Peterwood Way Croydon Surrey CR0 4UQ in data 03 mar 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2015 al 30 mar 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Nalin Morjaria come amministratore in data 01 giu 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jayanti Chimanbhai Patel Junior come amministratore in data 01 giu 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Heena Patel come amministratore in data 01 giu 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Kirit Chimanbhai Patel Junior come amministratore in data 01 giu 2015 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Kirit Chimanbhai Patel come amministratore in data 01 ago 2013 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ameetkumar Ramnbhai Patel come segretario in data 01 giu 2015 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bhavin Morjaria come amministratore in data 01 giu 2015 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Spa Pharmacy 4 Westgate Ripon North Yorkshire HG4 2AT a Lion House Red Lion Street London WC1R 4GB in data 11 giu 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Winn and Co 62-63 Westborough Scarborough North Yorkshire YO11 1TS* in data 11 dic 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 7 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Chi sono gli amministratori di MARSDENS PHARMACY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATEL, Ameetkumar Ramnbhai | Segretario | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | 198473160001 | |||||||
PATEL, Heena | Amministratore | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 62369320002 | ||||
PATEL JUNIOR, Jayanti Chimanbhai | Amministratore | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | England | British | Director | 174158560001 | ||||
PATEL JUNIOR, Kirit Chimanbhai | Amministratore | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | England | British | Director | 101281110001 | ||||
CLARKE, Celia Jean | Segretario | West Mews Boldron Lane Startforth DL12 9AR Barnard Castle Co Durham | British | 23459300001 | ||||||
HERDMAN, Nigel Dale | Segretario | 2 Westfield Drive NE3 4XT Gosforth Newcastle Upon Tyne | British | Pharmacist | 48892640006 | |||||
MARSDEN, Hazel Ann | Segretario | Bishopton HG4 2QL Ripon Bishopton Rise North Yorkshire | British | Company Director | 44407680001 | |||||
CLARKE, Celia Jean | Amministratore | West Mews Boldron Lane Startforth DL12 9AR Barnard Castle Co Durham | British | Company Director/Housewife | 23459300001 | |||||
CLARKE, Colin | Amministratore | West Mews 7 Boldron Lane DL12 9AR Barnard Castle County Durham | British | Pharmacist | 71297180001 | |||||
CLARKE, Colin | Amministratore | West Mews 7 Boldron Lane DL12 9AR Barnard Castle County Durham | British | Company Director/Pharmacist | 71297180001 | |||||
HERDMAN, Alison Mary | Amministratore | 2 Westfield Drive NE3 4XT Gosforth Newcastle Upon Tyne | England | British | Pharmacist | 22785460006 | ||||
HERDMAN, Nigel Dale | Amministratore | 2 Westfield Drive NE3 4XT Gosforth Newcastle Upon Tyne | England | British | Pharmacist | 48892640006 | ||||
MARSDEN, Hazel Ann | Amministratore | Bishopton HG4 2QL Ripon Bishopton Rise North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 44407680001 | ||||
MARSDEN, Richard Stephen | Amministratore | Bishopton HG4 2QL Ripon Bishopton Rise North Yorkshire | England | British | Pharmacist | 19086970001 | ||||
MORJARIA, Bhavin, Mr. | Amministratore | Sandringham Road N22 6RB London 25 Uk | Uk | British | Director | 165434900001 | ||||
MORJARIA, Nalin | Amministratore | Sandringham Road N22 6RB London 25 Uk | Uk | British | Occupational Psychologist | 13151460001 | ||||
PATEL, Kirit Chimanbhai | Amministratore | Red Lion Street WC1R 4GB London Lion House United Kingdom | England | British | Director | 11545120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MARSDENS PHARMACY LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.S. Marsden (Chemist) Limited | 06 apr 2016 | Peterwood Way CR0 4UQ Croydon 2 Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MARSDENS PHARMACY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 30 nov 2012 Consegnato il 06 dic 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the group (or any group member)on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 nov 2003 Consegnato il 21 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage l/h property 86 galgate barnard castle co durham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 19 mag 1999 Consegnato il 02 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and herdman pharmacies (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 mag 1999 Consegnato il 02 giu 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 86 galgate,barnard castle,durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 16 nov 1994 Consegnato il 18 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 27 nov 1981 Consegnato il 28 nov 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 86 glagate bernard castle, co. Durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0