PIPPA DEE PARTIES LIMITED

PIPPA DEE PARTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPIPPA DEE PARTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00924601
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PIPPA DEE PARTIES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PIPPA DEE PARTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Church Bridge House
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PIPPA DEE PARTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PIPPA DEE PARTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr Michael Arnaouti come amministratore in data 17 dic 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Michael Arnaouti come segretario in data 17 dic 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Ashcroft come segretario in data 16 dic 2021

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Ashcroft come amministratore in data 16 dic 2021

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 mar 2021

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 mar 2020

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Philip Binns Maudsley come amministratore in data 26 mar 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 mar 2019

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Ashcroft il 02 apr 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Binns Maudsley il 02 apr 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Murdoch Caldwell il 01 apr 2018

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Rosgill Group Limited come persona con controllo significativo il 02 mar 2018

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4th a Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE in data 01 mar 2018

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Timothy John Kowalski come amministratore in data 05 apr 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mark Ashcroft come amministratore in data 06 apr 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Stuart Murdoch Caldwell come amministratore in data 06 apr 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PIPPA DEE PARTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARNAOUTI, Michael
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Segretario
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    290653820001
    ARNAOUTI, Michael
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    EnglandBritish539040004
    CALDWELL, Stuart Murdoch
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish229000880001
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165368920001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Segretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    British14333000007
    CANN, Geoffrey
    11 Malmesbury Avenue
    Midway
    DE11 7PS Swadlincote
    Derbyshire
    Segretario
    11 Malmesbury Avenue
    Midway
    DE11 7PS Swadlincote
    Derbyshire
    British12477370001
    HALE, Donald
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    British75316130001
    ASHCROFT, Mark
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish113691350001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United KingdomBritish14333000007
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish143093130001
    HALE, Donald
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Trees House Staupes Road
    High Birstwith
    HG3 2LF Harrogate
    North Yorkshire
    British75316130001
    JOHNSON, David Anthony
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    United KingdomBritish157156750001
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    Amministratore
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritish75327660001
    KING, Dennis
    13 Dower House Crescent
    TN4 0TT Southborough
    Kent
    Amministratore
    13 Dower House Crescent
    TN4 0TT Southborough
    Kent
    British55754500001
    KITE, Ronald
    Keston Hall Lane
    Doveridge
    DE6 5NQ Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Keston Hall Lane
    Doveridge
    DE6 5NQ Ashbourne
    Derbyshire
    British13131070001
    KOWALSKI, Timothy John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    UkBritish153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish15967010001
    MOUNTFORD, Ewart
    11 Ambleside Court
    CW12 4HZ Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    11 Ambleside Court
    CW12 4HZ Congleton
    Cheshire
    British13300230001
    SIDDLE, Roger William John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    EnglandBritish46903210001
    WILLIAMS, Keith John
    12 The Hay Barn
    Walmley
    B76 1DE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    12 The Hay Barn
    Walmley
    B76 1DE Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish12477390001
    WOODS, Roger Slater
    229 Burton Road
    Branston
    DE14 3DR Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    229 Burton Road
    Branston
    DE14 3DR Burton On Trent
    Staffordshire
    British13300240001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PIPPA DEE PARTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01721195
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PIPPA DEE PARTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 mag 1991
    Consegnato il 05 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 nov 1988
    Consegnato il 13 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 01 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee and debenture
    Creato il 04 lug 1977
    Consegnato il 08 lug 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any at the other los named therein
    Brevi particolari
    All that property, undertaking & assets charged by the principal deed & further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1977Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 23 lug 1976
    Consegnato il 16 ago 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other los named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property, undertaking & asstes charged by the principal deed & further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1976Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 nov 1973
    Consegnato il 14 nov 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the two other companies named therein
    Brevi particolari
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charges.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 1973Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0