BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED

BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00948809
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Woolsington House
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    D.F.W. GOLDING (ANGLIA) LIMITED 20 giu 198620 giu 1986
    D.F.W. GOLDING LIMITED27 feb 196927 feb 1969

    Quali sono gli ultimi bilanci di BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Seaton Burn House Dudley Lane Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6BE a Woolsington House Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BF in data 25 ago 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Jayne Patricia Powell come segretario in data 30 apr 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Simon Scougall come segretario in data 30 apr 2020

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 gen 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2019

    2 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCOUGALL, Simon
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Segretario
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    269299850001
    ADEY, Keith Derek
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Amministratore
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    United KingdomBritishGroup Finance Director166483540002
    HONEYMAN, Jason Michael
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Amministratore
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    EnglandBritishDirector237437010001
    POWELL, Jayne Patricia
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    253468180001
    SCOUGALL, Simon
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    205018840001
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British62440010001
    WRIGHTSON, Gilbert Kevin
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British51453140002
    AYRES, Edward Francis
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    EnglandBritishDirector83605650003
    BELL, Ashley Kenrick
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director4620460001
    BELL, Kenneth
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    BritishCompany Director549680001
    DAWE, Howard Carlton
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    Amministratore
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director37782520006
    HADDRELL, Keith Sydney
    Avon
    Peldon Road Abberton
    CO5 7PB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Avon
    Peldon Road Abberton
    CO5 7PB Colchester
    Essex
    EnglandBritishCompany Director108901110001
    LEITCH, Alistair Mcleod
    The Red House
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    The Red House
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director83848200001
    ROBSON, Alan George
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Director3844820005
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCommercial Director62440010001
    WARBURTON, Derek
    Brooklands Tye
    7 John Raven Court, Feering
    CO5 9NB Colchester
    Essex
    Amministratore
    Brooklands Tye
    7 John Raven Court, Feering
    CO5 9NB Colchester
    Essex
    BritishCompany Director101798130002
    WATSON, John Knowlton
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishChief Executive72766290002

    Chi sono le persone con controllo significativo di BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    D.F.W. Golding Limited
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    06 apr 2016
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Registry
    Numero di registrazione1991200
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BELLWAY HOMES (ANGLIA) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 27 apr 1987
    Consegnato il 08 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Millfield house, barnston in the county of essex.
    Persone aventi diritto
    • Bellway (Builders) Limited
    Transazioni
    • 08 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1987
    Consegnato il 12 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000.
    Brevi particolari
    The dwellinghouse and garden k/a millfield house barnston great dunmow essex together with the garden thereof.
    Persone aventi diritto
    • Roger James Barnard.
    Transazioni
    • 12 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 06 feb 1987
    Consegnato il 10 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land and premises k/as millfield house chelmsford road and barnston road great dunmow essex. Floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 10 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1986
    Consegnato il 09 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & premises at the rear of 215/217 (odd nos. Only). High street kelvedon. Essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 25 nov 1986
    Consegnato il 26 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £107,000.
    Brevi particolari
    Land comprising part of the old omnibus depot at high street, kelvedon essex.
    Persone aventi diritto
    • Douglas Frederick Wyn Golding.
    Transazioni
    • 26 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 29 ott 1986
    Consegnato il 18 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land k/a site b, phase vi south woodham ferrers town centre title no:- ex 168296.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 mag 1986
    Consegnato il 06 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or D.F.W. golding (western) limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Floating charge all of the company's undertaking & goodwill & its property assets & rights (see doc 50 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 mar 1986
    Consegnato il 09 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Site at wickford avenue, pitsea, basildon, essex.
    Persone aventi diritto
    • First National Finance Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 09 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 nov 1985
    Consegnato il 08 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land at laindon, basildon in the county of essex forming part of langdon hills north 4TH housing areas (the badgers estate - phase 111).
    Persone aventi diritto
    • First National Finance Corporation PLC.
    Transazioni
    • 08 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1985
    Consegnato il 03 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate to the east of betterton road and lying to the south of frederick road, rainham, essex t/no s egl 23215, egl 27605, egl 27605, egl 78804, egl 140869 & egl 145140 together with unregistered land &. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on building agreement
    Creato il 08 mag 1985
    Consegnato il 15 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Water tower estate, mill lane, kelvedon hatch, brentwood essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1984
    Consegnato il 26 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - land fronting the chase, great totham, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on building agreement and licence
    Creato il 31 ott 1983
    Consegnato il 08 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the interest of the company in and all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company (see doc M42 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 lug 1983
    Consegnato il 11 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at the chase, great totham, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 08 mar 1983
    Consegnato il 17 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the interest of the company in, and all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement and licence dated 20 dec 1982 (for full details see doc no M40).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1983
    Consegnato il 04 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a all that piece or parcel of land at one time part of warrens farm situate in the parish of feering essex and k/a village field or death croft.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 10 dic 1982
    Consegnato il 16 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 apr 1982
    Consegnato il 20 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at the chase, kelvedon, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 feb 1982
    Consegnato il 24 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at 41/5 bridge street witham essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 10 dic 1981
    Consegnato il 17 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the building agreement dated 9.4.81
    Brevi particolari
    F/H land at east street great coggeshall essex described in a conveyance dated 14.5.81. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1981Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 17 ago 1981
    Consegnato il 04 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the building agreement dated 9.4.81
    Brevi particolari
    All the interest of the company in a building agreement dated 9.4.81 between basildon development corporation and the company relating to heathleigh, north housing area langdon hills basildon essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignments
    Creato il 17 ago 1981
    Consegnato il 04 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the building agreement dated 9.4.81
    Brevi particolari
    All monies due or owing to the company under the building agreement dated 9.4.81 between the company and basildon development corporation and D.F.W. golding LTD relating to heathleigh north housing area langdon hills basildon essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 08 gen 1981
    Consegnato il 22 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land adjoining oak cottage chelmsford road, felstead, essex.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 07 feb 1980
    Consegnato il 15 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at albert road, witham, essex as comprised in a conveyance dated 2/10/78.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 dic 1979
    Consegnato il 17 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as coach and bus depot, high street, kelvedon, as described in a conveyance dated 19-12-79.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0