Gilbert Kevin WRIGHTSON
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Gilbert |
Secondo nome | Kevin |
Cognome | WRIGHTSON |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 71 |
Totale | 71 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEATON GR SPV 14 LIMITED | 04 apr 2009 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
ADRIATIC LAND 4 (GR1) LIMITED | 04 apr 2009 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
ASHBERRY HOMES LIMITED | 04 apr 2009 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
ADRIATIC LAND 9 (GR1) LIMITED | 03 apr 2009 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY HOUSING TRUST LIMITED | 18 giu 2005 | 31 gen 2016 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | |
BARKING RIVERSIDE LIMITED | 26 mar 2004 | 31 gen 2016 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | |
BELLWAY P L C | 01 ago 2002 | 31 gen 2016 | Attiva | Company Secretary | Segretario | Seaton Burn House Dudley Lane NE13 6BE Seaton Burn Newcastle Upon Tyne | British | |
HOMES2LET LIMITED | 06 gen 1999 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BULLDOG PREMIUM GROWTH I LIMITED | 21 apr 1998 | 31 gen 2016 | Attiva | Company Secretary | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | |
BELLWAY PROPERTIES LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY (BUILDERS) LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
GEORGE BLACKETT LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
J. T. B. (CHAPEL FARM) ESTATES LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
J.T.B.ESTATES LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY (SERVICES) LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
SEATON THIRTEEN LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
SEATON ELEVEN LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
LITROSE INVESTMENTS LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
JOHN T BELL & SONS (1976) LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY TRUSTEE COMPANY LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY HOMES LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Attiva | Segretario | Seaton Burn House Dudley Lane NE13 6BE Seaton Burn Newcastle Upon Tyne | British | ||
SEATON TWELVE LIMITED | 28 gen 2009 | 31 gen 2016 | Sciolta | Company Secretary | Amministratore | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British |
THE VICTORIA DOCK COMPANY LIMITED | 01 ott 2008 | 31 gen 2016 | Sciolta | Co Director | Amministratore | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British |
BELLWAY I LIMITED | 17 mar 2006 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY HOUSEBUILDERS LIMITED | 17 mar 2006 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
MOORFIELD INVESTMENTS LIMITED | 16 mar 2006 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY HOMES (NORTH SOLIHULL) LIMITED | 25 mag 2005 | 31 gen 2016 | Sciolta | Co Secretary | Amministratore | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British |
THE VICTORIA DOCK COMPANY LIMITED | 22 mag 2000 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
SEATON EIGHT LIMITED | 23 feb 2000 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
METIER PROPERTIES LIMITED | 18 feb 2000 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
THE BARKING REACH COMPANY LIMITED | 25 mag 1999 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY HOMES (CUPERNHAM LANE) LIMITED | 21 gen 1999 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BULLDOG PREMIUM GROWTH II LIMITED | 21 apr 1998 | 31 gen 2016 | Sciolta | Company Secretary | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | |
TERRACES LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | ||
BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED | 01 feb 1997 | 31 gen 2016 | Sciolta | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0