GLOBAL CASTORS LIMITED

GLOBAL CASTORS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLOBAL CASTORS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01151232
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLOBAL CASTORS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GLOBAL CASTORS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Colson Castors Ltd Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLOBAL CASTORS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GLOBAL CASTORS AND HARDWARE LIMITED13 dic 197313 dic 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBAL CASTORS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per GLOBAL CASTORS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 apr 2016

    Stato del capitale al 19 apr 2016

    • Capitale: GBP 6,666
    SH01

    Cessazione della carica di Richard William White come amministratore in data 18 apr 2016

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account and capital redemption reserve 16/12/2015
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Derrick James Towell come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Hinds come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2015

    Stato del capitale al 27 apr 2015

    • Capitale: GBP 6,666
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Mr John Andrew Smithies come amministratore in data 04 ago 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr John Andrew Smithies come segretario in data 04 ago 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Derrick James Towell come segretario in data 04 ago 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2014

    Stato del capitale al 25 apr 2014

    • Capitale: GBP 6,666
    SH01

    Nomina di Mr John Hinds come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard William White come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Lilly come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Thomas William Blashill come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di GLOBAL CASTORS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Segretario
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    190475660001
    BLASHILL, Thomas William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    United StatesAmerican181117260001
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    EnglandBritish153425220003
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    British51615270002
    HOLT, Doreen Ann
    The Old Rectory
    GL4 8LD Brimpsfield
    Glos
    Segretario
    The Old Rectory
    GL4 8LD Brimpsfield
    Glos
    British26587680001
    LODGE, Freda Veronica
    3 Westbourne Drive
    GL52 2QG Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    3 Westbourne Drive
    GL52 2QG Cheltenham
    Gloucestershire
    British34148420001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Segretario
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Segretario
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    British107375020001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Segretario
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    CHAHALIS, Scott Christian
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    UsaUnited States157829560001
    DAVIES, John Bernard
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    Amministratore
    22 Meadowside
    Ashford
    EX31 4BS Barnstaple
    Devon
    British2874530001
    DAVIES, John Roger
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    British29214160002
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish51615270002
    HARRINGTON, Ronald
    3 Beacon Castle
    Granville Road
    EX34 8AS Ilfracombe
    Devon
    Amministratore
    3 Beacon Castle
    Granville Road
    EX34 8AS Ilfracombe
    Devon
    British51572040001
    HINDS, John
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    UsaAmerican185679720001
    HOLT, Doreen Ann
    The Old Rectory
    GL4 8LD Brimpsfield
    Glos
    Amministratore
    The Old Rectory
    GL4 8LD Brimpsfield
    Glos
    British26587680001
    LILLY, Robert
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritish97998580001
    LONSDALE, David Nigel
    The Old Rectory
    GL4 8LD Brimpsfield
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    GL4 8LD Brimpsfield
    Gloucestershire
    British89941510001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    PRITZKER, Robert Alan
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    Amministratore
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    United StatesAmerican47230840001
    SHIPLEY, Robert
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    Amministratore
    The Cottage Chapel Lane
    Ombersley
    WR9 0DT Worcester
    British43762210001
    SMITH, Christopher Joseph
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    UsaAmerican157830370001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    United StatesAmerican98409710001
    VEALE, Stuart Michael
    45 St Quintin Avenue
    W10 6NZ London
    Amministratore
    45 St Quintin Avenue
    W10 6NZ London
    British55936180001
    VRESICS, John J
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    Amministratore
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    United StatesUsa152264500001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Amministratore
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    WHITE, Richard William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Colson Castors Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish184103760001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GLOBAL CASTORS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Bagnall Street
    England
    06 apr 2016
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Bagnall Street
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02879952
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    GLOBAL CASTORS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Letter of charge
    Creato il 03 ott 1995
    Consegnato il 07 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the castor company limited and/or british castors limited and/or J.B.D.plastics limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies to the credit of any accounts of the company in the books of the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 25 apr 1994
    Consegnato il 29 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies dur or to become dur from the castor company limited and/or british castors limited or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of any account of the company in the banks books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 apr 1994
    Consegnato il 03 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 03 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 22 apr 1994
    Consegnato il 28 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Stone Investments (Number 2) Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 03 apr 1991
    Consegnato il 19 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £16,200
    Brevi particolari
    Factory premises at king alfred's way cheltenham gloucestershire.
    Persone aventi diritto
    • Pennant Audio Visual Systems Limited
    Transazioni
    • 19 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 30 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See schedule attached to form 395 for list of chattels.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 ott 1990
    Consegnato il 05 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 05 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0