BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED

BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01447567
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SER (UK) LIMITED24 dic 199824 dic 1998
    PAFEC C.A.E. LIMITED22 mar 198522 mar 1985
    CHERRYARGO LIMITED07 set 197907 set 1979

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 lug 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 giu 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018

    2 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2017

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    5 pagineAA

    Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mag 2016

    Stato del capitale al 09 mag 2016

    • Capitale: GBP 403,465
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2015

    Stato del capitale al 28 mag 2015

    • Capitale: GBP 403,465
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    5 pagineAA

    Nomina di David John Meaden come amministratore in data 22 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Adel Bedry Al-Saleh come amministratore in data 22 dic 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    British65186080003
    AUNGLES, Glenn
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    British67690750001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    British75357260001
    MCLACHLAN, Iain
    High Banks
    Pailton Road
    CV23 0HQ Harborough Magna
    Warwickshire
    Segretario
    High Banks
    Pailton Road
    CV23 0HQ Harborough Magna
    Warwickshire
    British87194100001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding 2
    Peoplebuilding Estate
    HP2 4NW Maylands Avenue Hemel Hempstead
    Herts
    Segretario
    Peoplebuilding 2
    Peoplebuilding Estate
    HP2 4NW Maylands Avenue Hemel Hempstead
    Herts
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHAW, Keith George, Dr
    9 Fairway Drive
    Beeston
    NG9 4BN Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    9 Fairway Drive
    Beeston
    NG9 4BN Nottingham
    Nottinghamshire
    British10642390001
    WYATT, Andrew James
    The Old School Strelley Village
    Strelley Road
    NG8 6PB Nottingham
    Segretario
    The Old School Strelley Village
    Strelley Road
    NG8 6PB Nottingham
    British66015770001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    AUNGLES, Glenn
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 Bridgford Road
    West Bridgford
    NG2 6AN Nottingham
    Nottinghamshire
    British67690750001
    BARNES, Kenneth Roy
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    Amministratore
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    British33463930001
    BLACKHURST, Ian Robert
    5a Bute Drive
    BH23 5LE Highcliffe
    Dorset
    Amministratore
    5a Bute Drive
    BH23 5LE Highcliffe
    Dorset
    British75399750001
    BOLD, Stephen John
    28 Boundary Road
    NG2 7BZ West Bridgford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    28 Boundary Road
    NG2 7BZ West Bridgford
    Nottinghamshire
    British75399610001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    HENSHELL, Kathleen Marian
    Strelley Hall
    Strelley
    NG8 6PE Nottingham
    Amministratore
    Strelley Hall
    Strelley
    NG8 6PE Nottingham
    EnglandBritish48049200001
    HENSHELL, Richard David
    Strelley Hall
    Strelley
    NG8 6PE Nottingham
    Amministratore
    Strelley Hall
    Strelley
    NG8 6PE Nottingham
    EnglandBritish1216720001
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    OTHACEHE, Laurent
    9 Parker Gardens
    Stapleford
    NG9 8QG Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    9 Parker Gardens
    Stapleford
    NG9 8QG Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomFrench76247530001
    REINHARDT, Gert
    Im Weisengrund 15
    Neustadt/Wied
    Rheinland Pfalz D-53577
    Germany
    Amministratore
    Im Weisengrund 15
    Neustadt/Wied
    Rheinland Pfalz D-53577
    Germany
    German61765920001
    SHAW, Keith George, Dr
    9 Fairway Drive
    Beeston
    NG9 4BN Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    9 Fairway Drive
    Beeston
    NG9 4BN Nottingham
    Nottinghamshire
    British10642390001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    STOREY, Philip Adrian
    9943 Lawyers Road
    Vienna 22181
    FOREIGN Virginia Usa
    Amministratore
    9943 Lawyers Road
    Vienna 22181
    FOREIGN Virginia Usa
    British58443560001
    WERBLOW, Warren
    Turnberry Grange
    Barnet Road
    EN5 3JT Arkley
    Herts
    Amministratore
    Turnberry Grange
    Barnet Road
    EN5 3JT Arkley
    Herts
    British16089010001
    WILLIAMSON, Ian
    8 Wentworth Close
    Kibworth
    LE8 0XB Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    8 Wentworth Close
    Kibworth
    LE8 0XB Leicester
    Leicestershire
    British60920680003
    WYATT, Andrew James
    The Old School Strelley Village
    Strelley Road
    NG8 6PB Nottingham
    Amministratore
    The Old School Strelley Village
    Strelley Road
    NG8 6PB Nottingham
    British66015770001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04132471
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 mar 2001
    Consegnato il 30 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 ago 1987
    Consegnato il 17 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Office 1 in the isleworth business complex at st. John's road, isleworth l/b of hounslow and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 giu 1980
    Consegnato il 27 giu 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £74,677 all and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    New prime 750 digital computer, 5D, hz 512 k bytes memory complete with additional 512 k bytes error correcting memory; 80M byte dix sub system 50HZ including controller and uncillary equipment. Serial no. Fn 303.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 27 giu 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 09 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 gen 1980
    Consegnato il 24 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank
    Transazioni
    • 24 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 09 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BLUE 8 TECHNOLOGIES (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 giu 2019Inizio della liquidazione
    12 ago 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0