BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED

BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01480543
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Woolsington House
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BELLWAY (HERTFORDSHIRE) LIMITED 12 nov 198712 nov 1987
    D. F. W. GOLDING (HERTFORD) LIMITED18 lug 198318 lug 1983
    GOLDING DEVELOPMENTS (MALDON) LIMITED20 feb 198020 feb 1980

    Quali sono gli ultimi bilanci di BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Seaton Burn House Dudley Lane Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6BE a Woolsington House Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BF in data 25 ago 2020

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Simon Scougall come segretario in data 30 apr 2020

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jayne Patricia Powell come segretario in data 30 apr 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2019

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2018

    5 pagineAA

    Nomina di Mrs Jayne Patricia Powell come segretario in data 12 dic 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Scougall come segretario in data 12 dic 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Jason Michael Honeyman come amministratore in data 12 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Knowlton Watson come amministratore in data 12 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward Francis Ayres come amministratore in data 31 lug 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Edward Francis Ayres il 05 mag 2017

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCOUGALL, Simon
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Segretario
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    269300880001
    ADEY, Keith Derek
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Amministratore
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    United KingdomBritish166483540002
    HONEYMAN, Jason Michael
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Amministratore
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    EnglandBritish237437010001
    POWELL, Jayne Patricia
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    253468670001
    SCOUGALL, Simon
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    205019320001
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British62440010001
    WRIGHTSON, Gilbert Kevin
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British51453140002
    AYRES, Edward Francis
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    EnglandBritish83605650003
    BELL, Ashley Kenrick
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British4620460001
    BELL, Kenneth
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    British549680001
    DAWE, Howard Carlton
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    Amministratore
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    United KingdomBritish37782520006
    LEITCH, Alistair Mcleod
    The Red House
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    The Red House
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish83848200001
    ROBSON, Alan George
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    British3844820005
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish62440010001
    WATSON, John Knowlton
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish72766290002

    Chi sono le persone con controllo significativo di BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    D.F.W. Golding Limited
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    06 apr 2016
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Registry
    Numero di registrazione1991200
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BELLWAY HOMES (HERTFORDSHIRE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 17 mar 1987
    Consegnato il 18 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at shenley lodge, milton keynes, buckingham. (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co. Limited.
    Transazioni
    • 18 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 mar 1987
    Consegnato il 10 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    40-50 (evens) riverdene road ilford essex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1986
    Consegnato il 16 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45A, 47A, 47 desford road silvertown london E16.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 dic 1986
    Consegnato il 09 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 9 high road and land on the south west side of new road broxbourne hertfordshire title no's hd 188252, hd 189216 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 26 ago 1986
    Consegnato il 03 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An assignment of the benefit of a licence agreement dated 20/3/86 and made between milton keynes development corporation and the company relating to plot 14A energy world, sherley lodge, milton keynes, buckingham fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. (Including trade fixtures & fittings).
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transazioni
    • 03 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 giu 1986
    Consegnato il 20 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land fronting high road broxbourne, hertfordshire k/a the lawns drive broxbourne fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery (including trade fixtures & fittings).
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transazioni
    • 20 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 30 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1986
    Consegnato il 06 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    141/153 hertford road, enfield, london fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixtures fixed plant and machinery (including trade fixtures & fittings).
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 set 1985
    Consegnato il 23 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    252/258 turners hill cheshunt herts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transazioni
    • 23 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 dic 1984
    Consegnato il 24 dic 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) floating charge on all company's assets. 2) fixed charge on:- a) the acorns gibsfield thorley, bishops storford herts, b) 195/7 high street south east ham, london E6. 3) land at garnetts lane felsted, essex.4) assignment of building agreement relating to site B1 tollgate road becton, london E6.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co. Limited.
    Transazioni
    • 24 dic 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 13 set 1984
    Consegnato il 19 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at chestnut walk garnetts lane felstead essex title no. Ex 294355.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 apr 1984
    Consegnato il 11 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at thorley bishops stortford hertfordshire (sector 14C).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 24 feb 1984
    Consegnato il 05 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 nov 1983
    Consegnato il 17 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the old school house, 6 church street, ware, herts SG12 9EG.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0