ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED

ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01552189
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Colson Castors Ltd Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AWARDPROFIT LIMITED23 mar 198123 mar 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard William White come amministratore in data 18 apr 2016

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of capital redemption reserve 16/12/2015
    RES13

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2015

    Stato del capitale al 06 ago 2015

    • Capitale: GBP 165,000
    SH01

    Cessazione della carica di Derrick James Towell come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Hinds come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Mr John Andrew Smithies come segretario in data 04 ago 2014

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr John Andrew Smithies come amministratore in data 04 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Derrick James Towell come segretario in data 04 ago 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2014

    Stato del capitale al 28 lug 2014

    • Capitale: GBP 165,000
    SH01

    Nomina di Mr John Hinds come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard William White come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Lilly come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Thomas William Blashil come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Segretario
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    190475790001
    BLASHILL, Thomas William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    United StatesAmerican181117260001
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    EnglandBritish153425220003
    BREESE, David Gwyn
    40 Wimblebury Road
    Littleworth
    WS12 5HU Cannock
    Staffordshire
    Segretario
    40 Wimblebury Road
    Littleworth
    WS12 5HU Cannock
    Staffordshire
    British13050560002
    HUMPAGE, George
    25 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QF Walsall
    West Midlands
    Segretario
    25 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QF Walsall
    West Midlands
    British13050540001
    NICHOLLS, Eric Ernest Graham
    20 Waters Drive
    Four Oaks
    B74 4TQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    20 Waters Drive
    Four Oaks
    B74 4TQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British13065170002
    PARTRIDGE, Nigel Keith
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    Segretario
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    British9988090001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Segretario
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    British107375020001
    BREESE, David Gwyn
    40 Wimblebury Road
    Littleworth
    WS12 5HU Cannock
    Staffordshire
    Amministratore
    40 Wimblebury Road
    Littleworth
    WS12 5HU Cannock
    Staffordshire
    British13050560002
    CHAHALIS, Scott Christian
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    UsaUnited States157829560001
    CLAYTON, James Henry
    154 Eastgate
    Deeping St James
    PE6 8RD Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    154 Eastgate
    Deeping St James
    PE6 8RD Peterborough
    Cambridgeshire
    British81673380001
    HARRINGTON, Ronald
    13 Churchill Way
    EX39 1DF Northam
    Devon
    Amministratore
    13 Churchill Way
    EX39 1DF Northam
    Devon
    British102973230001
    HINDS, John
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    UsaAmerican185679720001
    HUMPAGE, George
    25 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QF Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    25 Northgate
    Aldridge
    WS9 8QF Walsall
    West Midlands
    British13050540001
    LILLY, Robert
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    EnglandBritish97998580001
    NICHOLLS, Eric Ernest Graham
    20 Waters Drive
    Four Oaks
    B74 4TQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    20 Waters Drive
    Four Oaks
    B74 4TQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British13065170002
    PARTRIDGE, Nigel Keith
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    Amministratore
    Camelot Barbican Lane
    EX32 8LB Barnstaple
    Devon
    United KingdomBritish9988090001
    PRITZKER, Robert Alan
    1740 North Cleveland
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60614
    Usa
    Amministratore
    1740 North Cleveland
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60614
    Usa
    United StatesAmerican47230840001
    SMITH, Christopher Joseph
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    UsaAmerican157830370001
    TOWELL, Derrick James
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    110 Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    United StatesAmerican98409710001
    WALKER, John Albert
    The Thatched House
    Tunley Sapperton
    GL7 6LW Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Thatched House
    Tunley Sapperton
    GL7 6LW Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish3026560001
    WHITE, Richard William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    EnglandBritish184103760001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Bagnall Street
    West Midlands
    England
    30 giu 2016
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    Bagnall Street
    West Midlands
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02879952
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ALDRIDGE PLASTICS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 25 set 1996
    Consegnato il 03 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental legal charge.
    Creato il 28 mar 1984
    Consegnato il 30 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on the bookdebts and other debts due or owing to the company both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 28 mar 1984
    Consegnato il 30 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of assignment of the following plant machinery challets or other equipment of the company 1 fercomatic F60 1 fercomatic 350 ton, ancillary equipment incl water towel and adelko printer.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 apr 1982
    Consegnato il 21 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mar 1982
    Consegnato il 24 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. Stock-in-trade, works-in-progress, pre-payments, stock exchange investments & cash with all buildings, fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transazioni
    • 24 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0