AC201 REALISATIONS LIMITED

AC201 REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAC201 REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01600753
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AC201 REALISATIONS LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANGLAIR LIMITED20 ott 198620 ott 1986
    AIRTEC LIMITED27 mar 198627 mar 1986
    ATC PNEUMATICS LIMITED09 set 198209 set 1982
    DOUBLEBADGE LIMITED30 nov 198130 nov 1981

    Quali sono gli ultimi bilanci di AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    9 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 mar 2015

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 mar 2014

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 mar 2013

    8 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 20 mar 2012

    6 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 set 2011

    6 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 mar 2011

    8 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    2 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 set 2010

    7 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    11 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    10 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 115 Burrell Road Ipswich Suffolk IP2 8AE* in data 09 apr 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagine2.12B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed anglair LIMITED\certificate issued on 31/03/10
    2 pagineCERTNM

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 mar 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    10 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    11 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return04 lug 2007

    legacy

    363(288)

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Segretario
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    SHANKS, Alastair Paul Henry
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    Amministratore
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    BritainBritish101167430002
    SHANKS, Alexander Gavin
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    Amministratore
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    ScotlandBritish21890001
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Amministratore
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    Segretario
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    British52221890002
    PRATT, Cyril Harry
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    British8832470001
    WOOLLHEAD, John Andrew
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    Segretario
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    British13072060002
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish47892490001
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish4250980001
    CHILTON, Albert Edmund
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    Amministratore
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    British6236180002
    FOSTER, Simon
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    British94152980001
    FRYER, Peter Kenneth
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Other79955580001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JACKSON, Frank
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    British10015550001
    KING, Geoffrey Edward
    27 Thirlmere Road
    Barrow On Soar
    LE12 8QQ Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    27 Thirlmere Road
    Barrow On Soar
    LE12 8QQ Loughborough
    Leicestershire
    British10425820001
    LATIMER, Stephen Berjie James
    154 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SD Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    154 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SD Norwich
    Norfolk
    British10425810001
    STANTON, Derek William
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    British10425830001
    URQUHART, Robert Todd
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British56397610002

    AC201 REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 5 pinfold road, thurmaston, leicester t/no LT130050. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land k/a 203 to 207 (odd) attercliffe road, sheffield t/nos SYK448819 and SYK343842. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 199/201/203 mile cross lane, norwich t/nos NK21866 and NK6883. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 115 burrell road ipswich t/no SK124923. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 gen 2004
    Consegnato il 22 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and trust debenture
    Creato il 07 ott 2002
    Consegnato il 09 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any of them to the trustee and or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 09 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 08 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 set 1983
    Consegnato il 27 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set off
    Creato il 07 feb 1983
    Consegnato il 18 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or jackson group PLC to the chargee
    Brevi particolari
    Sums standing to the credit of the company with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 02 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    AC201 REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 mar 2010Inizio dell'amministrazione
    20 mar 2012Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Caven
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    Praticante
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    John Gerard Montague
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    Praticante
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    2
    DataTipo
    20 mar 2012Inizio della liquidazione
    14 set 2016Data prevista di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Caven
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Praticante
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    John Gerard Montague
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    Praticante
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0