HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED

HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01622579
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POSTKEY LIMITED17 mar 198217 mar 1982

    Quali sono gli ultimi bilanci di HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Kevin Michael Stein come amministratore in data 17 nov 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Russell Scott Pattee come amministratore in data 17 nov 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ago 2012

    Stato del capitale al 29 ago 2012

    • Capitale: GBP 25,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Nomina di Mrs Monika Anna Frankow come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Wallis come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2009

    3 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2008

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRANKOW, Monika Anna
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    Segretario
    191 Barkby Road
    Troon Industrial Area
    LE4 9HX Leicester
    149673410001
    BECKER, Roger Paul
    Country Lake Estates Drive
    63005 Chesterfield
    1407
    Missouri
    Usa
    Amministratore
    Country Lake Estates Drive
    63005 Chesterfield
    1407
    Missouri
    Usa
    United StatesAmerican134923120001
    BLACKMORE, Steven Craig
    Se Windsor Ct
    Portland
    4430
    Oregon
    Usa
    Amministratore
    Se Windsor Ct
    Portland
    4430
    Oregon
    Usa
    United StatesAmerican129100160001
    COOKE, Roger Anthony
    Sw Myrtle Street
    97201 Portland
    1910
    Oregon
    United States
    Amministratore
    Sw Myrtle Street
    97201 Portland
    1910
    Oregon
    United States
    UsaUsa134747640001
    HAGEL, Shawn Rene
    Sw 107th Terrace
    Tigard
    Oregon
    15190
    97224
    Usa
    Amministratore
    Sw 107th Terrace
    Tigard
    Oregon
    15190
    97224
    Usa
    United StatesAmerican92352720002
    AYRES, Terence John
    Shawbury Farm Shustoke
    B46 2RX Coleshill
    West Midlands
    Segretario
    Shawbury Farm Shustoke
    B46 2RX Coleshill
    West Midlands
    British59265020001
    BIRD, Julian Patrick
    4 Manor Farm Court
    Back Road
    LE7 9LS Tilton On The Hill
    Leicestershire
    Segretario
    4 Manor Farm Court
    Back Road
    LE7 9LS Tilton On The Hill
    Leicestershire
    British16939950002
    WALLIS, Michael Raymond
    2 Bailey Close
    LE11 3PB Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    2 Bailey Close
    LE11 3PB Loughborough
    Leicestershire
    English16864370002
    AYRES, Graham Raymond
    The Homestead Dunns Lane
    Dordon
    B78 1BS Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    The Homestead Dunns Lane
    Dordon
    B78 1BS Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish62137040002
    AYRES, Graham Raymond
    9 Choyce Close
    CV9 3AY Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    9 Choyce Close
    CV9 3AY Atherstone
    Warwickshire
    British62137040001
    AYRES, Ray
    71 Malmesbury Road
    CV6 2HX Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    71 Malmesbury Road
    CV6 2HX Coventry
    West Midlands
    British15337840001
    AYRES, Terence John
    Shawbury Farm Shustoke
    B46 2RX Coleshill
    West Midlands
    Amministratore
    Shawbury Farm Shustoke
    B46 2RX Coleshill
    West Midlands
    British59265020001
    BIRD, Julian Patrick
    4 Manor Farm Court
    Back Road
    LE7 9LS Tilton On The Hill
    Leicestershire
    Amministratore
    4 Manor Farm Court
    Back Road
    LE7 9LS Tilton On The Hill
    Leicestershire
    British16939950002
    DONEGAN, Mark
    2130 Windham Oaks Court
    West Linn
    Or 97068
    Usa
    Amministratore
    2130 Windham Oaks Court
    West Linn
    Or 97068
    Usa
    American90933260002
    HAWKES, Geoffrey A
    2810 Nw Beuhla Vista Terrace
    Portland
    Oregon 97210
    Usa
    Amministratore
    2810 Nw Beuhla Vista Terrace
    Portland
    Oregon 97210
    Usa
    Us Citizen76227940001
    KIELY, Leonard
    Tykellen
    Mountshannon Road
    IRISH Castleconnell
    Co. Limerick
    Eire
    Amministratore
    Tykellen
    Mountshannon Road
    IRISH Castleconnell
    Co. Limerick
    Eire
    Irish57926150001
    KIRK, Michael David
    46 Shirley Road
    LE2 3LJ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    46 Shirley Road
    LE2 3LJ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish8642430002
    LARSSON, William Dean
    1865 Palisades Terrace
    Lake Oswego
    Oregon 97034
    Usa
    Amministratore
    1865 Palisades Terrace
    Lake Oswego
    Oregon 97034
    Usa
    American96758530001
    PATTEE, Russell Scott
    Se Norwood Loop
    Happy Valley
    11444
    Oregon 97086
    United States
    Amministratore
    Se Norwood Loop
    Happy Valley
    11444
    Oregon 97086
    United States
    United StatesAmerican132606280001
    ROSKOPF, Mark R
    9708 Nw Golden Avenue
    FOREIGN Vancouver
    Wa 98665
    Usa
    Amministratore
    9708 Nw Golden Avenue
    FOREIGN Vancouver
    Wa 98665
    Usa
    American92313320001
    STEIN, Kevin Michael
    Birch Leaf Court
    63005 Chesterfiled
    17711
    Missouri
    Usa
    Amministratore
    Birch Leaf Court
    63005 Chesterfiled
    17711
    Missouri
    Usa
    UsaUnited States138553520001

    HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 29 ago 1991
    Consegnato il 03 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 feb 1989
    Consegnato il 09 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises on the south west side of george street, attleborough pluneaton, warwickshire title no wk 245053 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 gen 1986
    Consegnato il 27 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1985
    Consegnato il 03 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises in george street attleborough nuneaton worvickshire title no. Wk 245053.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0