Steven Craig BLACKMORE
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Steven |
Secondo nome | Craig |
Cognome | BLACKMORE |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 0 |
Inattivo | 5 |
Dimesso | 24 |
Totale | 29 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITANIUM MC LIMITED | 24 gen 2013 | Sciolta | Treasurer Pcc | Amministratore | PO BOX 704 Witton Road B6 7UR Witton Birmingham | United States | American | |
TIMET UK (EXPORT) LIMITED | 24 gen 2013 | Sciolta | Treasurer Pcc | Amministratore | PO BOX 704 Witton B6 7UR Birmingham | United States | American | |
CHEVRON AEROSPACE GROUP LIMITED | 13 feb 2008 | Sciolta | Vice President And Treasurer | Amministratore | Se Windsor Ct Portland 4430 Oregon Usa | United States | American | |
SPS TECH TRADING LIMITED | 13 feb 2008 | Sciolta | Vice President And Treasurer | Amministratore | Se Windsor Ct Portland 4430 Oregon Usa | United States | American | |
HI-LIFE TOOLS (UK) LIMITED | 13 feb 2008 | Sciolta | Vice President And Treasurer | Amministratore | Se Windsor Ct Portland 4430 Oregon Usa | United States | American | |
K G COATING LIMITED | 01 ago 2014 | 20 lug 2018 | Attiva | Vice President And Treasurer | Amministratore | Sw Macadam Avenue Ste. 300 Portland 4650 Oregon 97239 United States | United States | American |
TIMET EUROPE LIMITED | 24 gen 2013 | 20 lug 2018 | Attiva | Treasurer Pcc | Amministratore | PO BOX 704 Holford Drive Birmingham B6 7UR West Midlands | United States | American |
TIMET UK LIMITED | 24 gen 2013 | 20 lug 2018 | Attiva | Treasurer Pcc | Amministratore | P.O.Box 704 Witton B6 7UR Birmingham | United States | American |
SPECIAL METALS WIGGIN LIMITED | 24 mar 2011 | 20 lug 2018 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Holmer Road HR4 9SL Hereford Wiggin Works | United States | American |
CALEDONIAN ALLOYS LIMITED | 14 gen 2010 | 20 lug 2018 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Wyman Gordon Complex Houstoun Road EH54 5BZ Livingston | United States | American |
SPS TECHNOLOGIES LIMITED | 13 feb 2008 | 20 lug 2018 | Attiva | Vice President And Treasurer | Amministratore | 191 Barkby Road Troon Industrial Area LE4 9HX Leicester | United States | American |
AETC LIMITED | 13 feb 2008 | 20 lug 2018 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Victoria Avenue Yeadon LS19 7AW Leeds West Yorkshire | United States | American |
WYMAN-GORDON LIMITED | 13 feb 2008 | 20 lug 2018 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Portland 4430 Se Windsor Ct Oregon United States | United States | American |
SPS AEROSTRUCTURES LIMITED | 13 feb 2008 | 20 lug 2018 | Attiva | Vice President And Treasurer | Amministratore | Sw Macadam Avenue Suite 300 97239 Portland 4650 Oregon United States | United States | American |
KG NEWCO LTD | 01 ago 2014 | 20 lug 2018 | Sciolta | Vice President And Treasurer | Amministratore | Sw Macadam Avenue Ste. 300 Portland 4650 Oregon 97239 United States | United States | American |
SOS METALS (EUROPE) HOLDINGS LTD | 31 dic 2013 | 20 lug 2018 | Sciolta | Treasurer | Amministratore | Langham Park Berristow Lane South Normanton DE55 2EG Derby Unit 5 Derbyshire United Kingdom | United States | American |
SOS METALS (UK) LIMITED | 31 dic 2013 | 20 lug 2018 | Sciolta | Treasurer | Amministratore | Berristow Lane DE55 2EG South Normanton Unit 5 Langham Park Derbyshire | United States | American |
CALEDONIAN ALLOYS GROUP LIMITED | 14 gen 2010 | 20 lug 2018 | Sciolta | Treasurer | Amministratore | Wyman Gordon Complex Houstoun Road EH54 5BZ Livingston | United States | American |
CHEVRON AEROSTRUCTURES LIMITED | 13 feb 2008 | 20 lug 2018 | Sciolta | Vice President & Treasurer | Amministratore | Sw Macadam Avenue Suite 300 97239 Portland 4650 Oregon United States | United States | American |
SPS CHEVRON LIMITED | 13 feb 2008 | 20 lug 2018 | Sciolta | Vice President And Treasurer | Amministratore | Portland 4430 Se Windsor Ct Oregon United States | United States | American |
SPECIAL METALS WIGGIN TRUSTEES LIMITED | 05 mar 2008 | 12 lug 2018 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Wiggin Works Holmer Road HR4 9SL Hereford | United States | American |
PCC UK GLOBAL HOLDINGS LIMITED | 24 gen 2013 | 20 giu 2018 | Attiva | Treasurer Pcc | Amministratore | PO BOX 704 Witton B6 7UR Birmingham West Midlands | United States | American |
PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED | 13 feb 2008 | 26 set 2013 | Sciolta | Vice President | Amministratore | Portland 4430 Se Windsor Ct Oregon Usa | United States | American |
SBP HOLDINGS LIMITED | 09 ago 2011 | 03 mag 2013 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Invincible Road GU14 7QU Farnborough 21 Hampshire United Kingdom | United States | American |
TRIUMPH STRUCTURES INTERNATIONAL, LTD. | 09 ago 2011 | 03 mag 2013 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Invincible Road GU14 7QU Farnborough 21 Hampshire United Kingdom | United States | American |
TRIUMPH AEROSPACE OPERATIONS UK, LTD. | 09 ago 2011 | 03 mag 2013 | Attiva | Treasurer | Amministratore | Invincible Road GU14 7QU Farnborough 21 Hampshire United Kingdom | United States | American |
AIRDROME PARTS CO.,LIMITED | 24 giu 2009 | 30 mar 2012 | Sciolta | Vp & Treasurer | Amministratore | Portland 4430 Se Windsor Ct Oregon Usa | United States | American |
A F AEROSPACE LIMITED | 24 giu 2009 | 30 mar 2012 | Sciolta | Vp & Treasurer | Amministratore | Portland 4430 Se Windsor Ct Oregon Usa | United States | American |
THE CALEY GROUP LIMITED | 14 gen 2010 | 14 feb 2011 | Sciolta | Treasurer | Amministratore | 4650 Sw Macadam Avenue Ste. 400 97239 Portland Precision Castparts Corp., Oregon United States | United States | American |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0