PARAMOUNT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARAMOUNT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01934366
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARAMOUNT LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova PARAMOUNT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARAMOUNT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARAMOUNT P.L.C.22 feb 198922 feb 1989
    SILVER BEAR P.L.C.29 lug 198529 lug 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARAMOUNT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PARAMOUNT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 13 nov 2013

    17 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 13 nov 2013

    17 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 apr 2013

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 18 ott 2012

    17 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 mag 2012

    39 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    61 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH in data 05 dic 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio modificato redatto al 02 gen 2011

    14 pagineAAMD

    legacy

    10 pagineMG01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Stephen Rushworth Smith come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di William Rollason come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 giu 2011

    Stato del capitale al 24 giu 2011

    • Capitale: GBP 4,157,690.4
    SH01

    Cessazione della carica di Matthew Emerson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr William Rollason come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Simon George Rowe come amministratore

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 29 giu 2010 al 29 dic 2010

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Mark Phillips come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Matthew Charles Emerson come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PARAMOUNT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROWE, Simon George
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Amministratore
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritish6894950002
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Segretario
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    British117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Segretario
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    British148079910001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Segretario
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    British130983750001
    JACKSON, Graham Michael, Dr
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    Segretario
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    British20761790001
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Segretario
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    BARBOUR, Anthony George
    Bolesworth Castle
    Tattenhall
    CH3 9HQ Chester
    Amministratore
    Bolesworth Castle
    Tattenhall
    CH3 9HQ Chester
    British1448620001
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Amministratore
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritish140766360001
    BRAMLEY, Michael Lloyd
    53 Spring Lane
    Burn Bridge
    HG3 1NP Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    53 Spring Lane
    Burn Bridge
    HG3 1NP Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish46914100003
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish106840540001
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Amministratore
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    British117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Amministratore
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish148079910001
    DAVIES, Paul
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    Amministratore
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    British5020990002
    DICKSON, Leslie Cranstoun
    10 Uplands Delamere Park
    Cuddington
    CW8 2XL Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    10 Uplands Delamere Park
    Cuddington
    CW8 2XL Northwich
    Cheshire
    British25070870001
    ELMAN, Ralph
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    Amministratore
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    British80068050001
    EMERSON, Matthew Charles
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8
    Amministratore
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8
    EnglandBritish61777750002
    FRYER, John Malcolm
    Old Stores 34a
    Ribchester Road
    BB1 9HU Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    Old Stores 34a
    Ribchester Road
    BB1 9HU Blackburn
    Lancashire
    British44961580001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Amministratore
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritish130983750001
    HUDD, David Leslie
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    Amministratore
    97 Gunterstone Road
    W14 9BT London
    EnglandBritish26032950002
    JONES, Leonard Edward
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    British76599820001
    KING, William James
    Springwood House
    Birch Heath Lane, Christleton
    CH3 7AP Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Springwood House
    Birch Heath Lane, Christleton
    CH3 7AP Chester
    Cheshire
    British64187110004
    LAWSON, Carole Mary
    34 Moss Bank Road
    WA11 7DE St Helens
    Merseyside
    Amministratore
    34 Moss Bank Road
    WA11 7DE St Helens
    Merseyside
    British48885070001
    LUNN, George Michael
    Fairmount
    17 Ledcameroch Road
    G61 4AB Bearsden Glasgow
    Dunbartonshire
    Amministratore
    Fairmount
    17 Ledcameroch Road
    G61 4AB Bearsden Glasgow
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish194960002
    MEARNS, Alexander
    1 Windsor Road
    Crosby
    L23 7TR Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    1 Windsor Road
    Crosby
    L23 7TR Liverpool
    Merseyside
    British35737020002
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Amministratore
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    EnglandBritish35557050001
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Amministratore
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    EnglandBritish35557050001
    MORTON, Brian George
    37 Meadow Vale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    37 Meadow Vale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    British22731400001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Amministratore
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NEILL, Ian Smeeton
    22 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    22 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish6744750002
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    PRICE, Robert Dennis
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    British22672440001
    ROE, Neil Clifford
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish100873710001
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Amministratore
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritish140347580001
    STANDING, Peter Heaton
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    British23728590001

    PARAMOUNT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A supplemental security, accession and confirmation deed
    Creato il 22 set 2011
    Consegnato il 28 set 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 17 lug 2009
    Consegnato il 27 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 set 2006
    Consegnato il 05 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 ago 2005
    Consegnato il 02 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 apr 2003
    Consegnato il 29 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 nov 1998
    Consegnato il 17 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (I) afon goch inn,flintshire;wa 642065;(ii) anchor inn,north shropshire; sl 55332;(iii) aston arms,vale royal,cheshire; ch 348040 plus 104 other properties listed on schedule;all plant,machinery,fixtures/fittings,furniture,equipment,etc thereon; the goodwill of business and proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 nov 1998
    Consegnato il 17 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 23 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement and any of the "security documents" (as defined in the assignment)
    Brevi particolari
    The policy numbered jgn 13988 dated 7TH january 1997 in an amount of £250,000 on the life of paul davies issued through J.D.bassett and others and all monies (including claims profits and bonuses ) payable thereunder and all other rights of the company therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1996
    Consegnato il 10 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H the bogie steamliner 81 salisbury street liverpool t/n MS355754 and by way of fixed charge all buildings and other structures any goodwill all plant machinery and other chattels the rental sums the proceeds of any claim under any insurance policy and by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over sale proceeds account
    Creato il 02 mar 1995
    Consegnato il 21 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement (as defined)
    Brevi particolari
    The sale proceeds account no.01539664 Opened in the books of the bank of scotland and all monies constituting the balance to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent for the Banks (as Defined)
    Transazioni
    • 21 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 14 feb 1995
    Consegnato il 17 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The spiral staircase old hall street liverpool together with any proceeds of insurance & all rents the benefit of all securities & guarantees & all interest due in respect thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    Bleak house 127, 129, 131 & 133 park hill road & 87, 89, 91 & 93 cockburn street liverpool with the proceeds of any sale the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The derby arms 365/367 mill street liverpool with the proceeds of any insurance the rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The new inn peasley cross lane st helens lancs and the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    Mount vernon 1 irvine street liverpool with the proceeds of any insurance the rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The poste house 23 cumberland street liverpool with the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The globe inn 44 park road liverpool with the proceeds of any insurance all rents & benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The leasowe castle 1 demesne street seacombe wallasey wirral merseyside with any proceeds of insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The salvation 199 walton road liverpool with the proceeds of any insurance the benefit of all guarantees all rents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The sun inn 43/45 mill lane macclesfield cheshire and the proceeds of any insurance all rents the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The smithfield 1062 ashton old road openshaw manchester with the proceeds of any insurance all rents & the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any interest rate agreement and the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    Owd kitts 14 glodwick oldham gtr manchester with any proceeds of any insurance the benefit of all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 23 nov 1994
    Consegnato il 08 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £96,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The rubber duck 5 strand road bootle liverpool.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1994
    Consegnato il 15 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £55,200 due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 24TH may 1994
    Brevi particolari
    The welcome inn 58 north john street st. Helens merseyside.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland(As Agent)
    Transazioni
    • 15 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PARAMOUNT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 nov 2011Inizio dell'amministrazione
    13 nov 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Praticante
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0