Matthew Charles EMERSON
Persona fisica
Titolo | Mr |
---|---|
Nome | Matthew |
Secondo nome | Charles |
Cognome | EMERSON |
Data di nascita | |
È un dirigente societario | No |
Incarichi | |
Attivo | 2 |
Inattivo | 0 |
Dimesso | 29 |
Totale | 31 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Professione | Ruolo | Indirizzo | Paese di residenza | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG G ENTERPRISES LIMITED | 01 mar 2004 | Attiva | Accountant | Amministratore | Nightingale Road GU1 1ER Guildford 30 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | |
BIG G ENTERPRISES LIMITED | 01 mar 2004 | Attiva | Accountant | Segretario | Nightingale Road GU1 1ER Guildford 30 Surrey United Kingdom | British | ||
SBR MANAGEMENT LIMITED | 26 lug 2021 | 05 set 2023 | Attiva | Accountant | Amministratore | Northumberland Avenue WC2N 5AP London Craven House 16 England | United Kingdom | British |
KELVIN LIGHTING LIMITED | 01 lug 2021 | 05 set 2023 | Attiva | Director | Amministratore | 16 Northumberland Avenue WC2N 5AP London Craven House United Kingdom | United Kingdom | British |
ATRIUM LIMITED | 01 lug 2021 | 05 set 2023 | Attiva | Director | Amministratore | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British |
PRETTY GREEN GROUP LIMITED | 12 gen 2018 | 28 feb 2019 | Sciolta | Financial Director | Amministratore | 1st Floor 25 - 31 London Street RG1 4PS Reading Central Point United Kingdom | United Kingdom | British |
PRETTY GREEN LIMITED | 12 gen 2018 | 28 feb 2019 | Sciolta | Financial Director | Amministratore | 1st Floor 25-31 London Street RG1 4PS Reading Central Point | United Kingdom | British |
TLBRUT LIMITED | 01 dic 2015 | 28 giu 2017 | Sciolta | Cfo | Amministratore | 13 Bramley Road W10 6SZ London Phoenix Brewery United Kingdom | United Kingdom | British |
BICTEM LIMITED | 01 dic 2015 | 28 giu 2017 | Sciolta | Cfo | Amministratore | 13 Bramley Road W10 6SZ London Phoenix Brewery United Kingdom | United Kingdom | British |
TL 2021 LIMITED | 08 giu 2015 | 28 giu 2017 | Sciolta | Cfo | Amministratore | 13 Bramley Road W10 6SZ London Phoenix Brewery | United Kingdom | British |
FB REALISATIONS 2017 LIMITED | 02 gen 2015 | 05 giu 2015 | Sciolta | Commercial Director | Amministratore | Ravenstone Hall Ashby Road LE67 2AA Ravenstone Estate Office Leicestershire | United Kingdom | British |
FB HOLDINGS 2017 LIMITED | 02 gen 2015 | 05 giu 2015 | Sciolta | Commercial Director | Amministratore | Ravenstone Hall Ashby Road, Ravenstone LE67 2AA Leicester Estate Office | United Kingdom | British |
ROBERT DYAS PROPERTY LIMITED | 01 dic 2012 | 29 mar 2013 | Attiva | Accountant | Amministratore | Cleeve Road KT22 7SD Leatherhead Cleeve Court | United Kingdom | British |
ROBERT DYAS HOLDINGS LIMITED | 01 dic 2012 | 29 mar 2013 | Attiva | Accountant | Amministratore | Cleeve Court Cleeve Road KT22 7SD Leatherhead Surrey | United Kingdom | British |
CLEEVE COURT HOLDINGS LIMITED | 01 dic 2012 | 29 mar 2013 | Attiva | Accountant | Amministratore | c/o C/O Robert Dyas Holdings Ltd Cleeve Road KT22 7SD Leatherhead Cleeve Court Surrey United Kingdom | United Kingdom | British |
CHEZ GERARD RESTAURANTS LONDON LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Attiva | Accountant | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British |
PARAMOUNT LIMITED | 30 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accountant | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8 | England | British |
PARAMOUNT RESTAURANTS LIMITED | 30 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accountant | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British |
CHEZ GERARD LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accountant | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British |
LEVIATHAN LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accountant | Amministratore | 8-10 Grosvenor Gardens Victoria SW1W 0DH London | England | British |
LIVEBAIT RESTAURANTS LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accontant | Amministratore | 8-10 Grosvenor Gardens Victoria SW1W 0DH London | England | British |
EX-RCC SUB-CO LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accountant | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British |
PARAMOUNT HOLDINGS LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accountant | Amministratore | 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH | United Kingdom | British |
REAL INNS LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Sciolta | Accountant | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British |
CHARLOTTE STREET RESTAURANTS PLC | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Liquidazione | Accountant | Amministratore | 8-10 Grosvenor Gardens Victoria SW1W 0DH London | England | British |
GROUPE CHEZ GERARD LIMITED | 18 giu 2010 | 23 dic 2010 | Liquidazione | Accountant | Amministratore | Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 8-10 | England | British |
BENSON GROUP LIMITED | 08 ago 2001 | 01 set 2003 | Sciolta | Accountant | Amministratore | 12 Niton Road TW9 4LH Richmond Surrey | British | |
BENSON GROUP LIMITED | 16 lug 2001 | 01 set 2003 | Sciolta | Segretario | 12 Niton Road TW9 4LH Richmond Surrey | British | ||
BENSON LIMITED | 16 lug 2001 | 01 set 2003 | Sciolta | Segretario | 12 Niton Road TW9 4LH Richmond Surrey | British | ||
BENSON MIDLANDS LIMITED | 16 lug 2001 | 01 set 2003 | Liquidazione | Segretario | 12 Niton Road TW9 4LH Richmond Surrey | British | ||
CHELSEA STORES LIMITED | 09 dic 1998 | 15 giu 2001 | Sciolta | Segretario | 12 Niton Road TW9 4LH Richmond Surrey | British |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0