SEATON FOURTEEN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SEATON FOURTEEN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01945008 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SEATON FOURTEEN LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SEATON FOURTEEN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Woolsington House Woolsington NE13 8BF Newcastle Upon Tyne England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SEATON FOURTEEN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BELLWAY HOMES (WEST MIDLANDS) LIMITED | 22 gen 1988 | 22 gen 1988 |
| BELLWAY (WEST MIDLANDS) LIMITED | 21 dic 1987 | 21 dic 1987 |
| D.F.W. GOLDING (WESTERN) LIMITED | 05 set 1985 | 05 set 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SEATON FOURTEEN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 lug 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per SEATON FOURTEEN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Seaton Burn House Dudley Lane Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6BE a Woolsington House Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BF in data 25 ago 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Jayne Patricia Powell come amministratore in data 14 apr 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jason Michael Honeyman come amministratore in data 14 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Derek Adey come amministratore in data 14 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed bellway homes (west midlands) LIMITED\certificate issued on 15/01/20 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 10 gen 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Jayne Patricia Powell come segretario in data 12 dic 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Scougall come segretario in data 12 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Jason Michael Honeyman come amministratore in data 12 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Knowlton Watson come amministratore in data 12 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Edward Francis Ayres come amministratore in data 31 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SEATON FOURTEEN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWELL, Jayne Patricia | Segretario | Woolsington NE13 8BF Newcastle Upon Tyne Woolsington House England | 253469060001 | |||||||
| POWELL, Jayne Patricia | Amministratore | Woolsington NE13 8BF Newcastle Upon Tyne Woolsington House England | England | British | 106388200001 | |||||
| SCOUGALL, Simon | Segretario | Seaton Burn House Dudley Lane NE13 6BE Seaton Burn Newcastle Upon Tyne | 205020380001 | |||||||
| STOKER, Peter John | Segretario | 53 Moor Crescent Gosforth NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 62440010001 | ||||||
| WRIGHTSON, Gilbert Kevin | Segretario | 53 Greystoke Park Gosforth NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne | British | 51453140002 | ||||||
| ADEY, Keith Derek | Amministratore | Seaton Burn House Dudley Lane NE13 6BE Seaton Burn Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 166483540002 | |||||
| AYRES, Edward Francis | Amministratore | Dudley Lane NE13 6BE Seaton Burn Seaton Burn House Newcastle Upon Tyne England | England | British | 83605650003 | |||||
| BELL, Ashley Kenrick | Amministratore | Holywell House 25 Glastonbury Grove Jesmond NE2 2HB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 4620460001 | ||||||
| BELL, Kenneth | Amministratore | Lough House Espley NE61 3DB Morpeth Northumberland | British | 549680001 | ||||||
| BURNETT, Peter | Amministratore | 8 Stoneleigh Close Four Oaks Park B74 2QS Sutton Coldfield West Midlands | British | 4789240001 | ||||||
| DAWE, Howard Carlton | Amministratore | Fenham Grange Fenham Le Moor NE70 7PN Belford Northumberland | United Kingdom | British | 37782520006 | |||||
| HONEYMAN, Jason Michael | Amministratore | Seaton Burn House Dudley Lane NE13 6BE Seaton Burn Newcastle Upon Tyne | England | British | 237437010001 | |||||
| LEITCH, Alistair Mcleod | Amministratore | Fairmoor NE61 3JL Morpeth The Red House Northumberland England | United Kingdom | British | 83848200001 | |||||
| ROBSON, Alan George | Amministratore | Seaton Burn House Dudley Lane Seaton Burn NE13 6BE Newcastle Upon Tyne | British | 3844820005 | ||||||
| STOKER, Peter John | Amministratore | 53 Moor Crescent Gosforth NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 62440010001 | |||||
| WATSON, John Knowlton | Amministratore | Seaton Burn House Dudley Lane NE13 6BE Seaton Burn Newcastle Upon Tyne | England | British | 72766290002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SEATON FOURTEEN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.F.W. Golding Limited | 06 apr 2016 | Dudley Lane Seaton Burn NE13 6BE Newcastle Upon Tyne Seaton Burn House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SEATON FOURTEEN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 23 ott 1989 Consegnato il 02 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 475,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargees | |
Brevi particolari F/H land and factory premises on the north east side of pool lane langley title no wr 5317. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 05 nov 1986 Consegnato il 12 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold land and premises north side of duke street sutton coalfield t/n wm 334934 floating charge all the undertaking goodwill assets and rights of the company present and future book or other debts goodwill see doc for fuller details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 ott 1986 Consegnato il 09 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal mortgage over land on the north east side of aldridge rd, streetley, walsall, W. midlands title no. Wm 353500 together with all buildings and fixtures goodwill and full benefit of any licences present & future.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 30 mag 1986 Consegnato il 06 giu 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or D.F.W. golding limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & premises north side of duke street, sutton coldfield, birmingham title no wm 334934 by way of floating charge all of the companys undertaking & goodwill & its property assets & rights (see doc 11 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 feb 1986 Consegnato il 06 mar 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plot of land at fladbury hereford and worcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 dic 1985 Consegnato il 02 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land in rectory lane harvington hereford & worcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 dic 1985 Consegnato il 02 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at fladbury hill fladbury hereford. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0