SEATON FOURTEEN LIMITED

SEATON FOURTEEN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSEATON FOURTEEN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01945008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SEATON FOURTEEN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SEATON FOURTEEN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Woolsington House
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SEATON FOURTEEN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BELLWAY HOMES (WEST MIDLANDS) LIMITED22 gen 198822 gen 1988
    BELLWAY (WEST MIDLANDS) LIMITED 21 dic 198721 dic 1987
    D.F.W. GOLDING (WESTERN) LIMITED05 set 198505 set 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di SEATON FOURTEEN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per SEATON FOURTEEN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da Seaton Burn House Dudley Lane Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6BE a Woolsington House Woolsington Newcastle upon Tyne NE13 8BF in data 25 ago 2020

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Mrs Jayne Patricia Powell come amministratore in data 14 apr 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jason Michael Honeyman come amministratore in data 14 apr 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Keith Derek Adey come amministratore in data 14 apr 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed bellway homes (west midlands) LIMITED\certificate issued on 15/01/20
    3 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 10 gen 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2019

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2018

    5 pagineAA

    Nomina di Mrs Jayne Patricia Powell come segretario in data 12 dic 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Scougall come segretario in data 12 dic 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Jason Michael Honeyman come amministratore in data 12 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Knowlton Watson come amministratore in data 12 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward Francis Ayres come amministratore in data 31 lug 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SEATON FOURTEEN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    POWELL, Jayne Patricia
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Segretario
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    253469060001
    POWELL, Jayne Patricia
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    Amministratore
    Woolsington
    NE13 8BF Newcastle Upon Tyne
    Woolsington House
    England
    EnglandBritish106388200001
    SCOUGALL, Simon
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    205020380001
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British62440010001
    WRIGHTSON, Gilbert Kevin
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    53 Greystoke Park
    Gosforth
    NE3 2DZ Newcastle Upon Tyne
    British51453140002
    ADEY, Keith Derek
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish166483540002
    AYRES, Edward Francis
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    Amministratore
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Seaton Burn House
    Newcastle Upon Tyne
    England
    EnglandBritish83605650003
    BELL, Ashley Kenrick
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Holywell House 25 Glastonbury Grove
    Jesmond
    NE2 2HB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British4620460001
    BELL, Kenneth
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Lough House
    Espley
    NE61 3DB Morpeth
    Northumberland
    British549680001
    BURNETT, Peter
    8 Stoneleigh Close
    Four Oaks Park
    B74 2QS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    8 Stoneleigh Close
    Four Oaks Park
    B74 2QS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British4789240001
    DAWE, Howard Carlton
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    Amministratore
    Fenham Grange Fenham Le Moor
    NE70 7PN Belford
    Northumberland
    United KingdomBritish37782520006
    HONEYMAN, Jason Michael
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish237437010001
    LEITCH, Alistair Mcleod
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    The Red House
    Northumberland
    England
    Amministratore
    Fairmoor
    NE61 3JL Morpeth
    The Red House
    Northumberland
    England
    United KingdomBritish83848200001
    ROBSON, Alan George
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    British3844820005
    STOKER, Peter John
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    53 Moor Crescent
    Gosforth
    NE3 4AQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish62440010001
    WATSON, John Knowlton
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Seaton Burn House
    Dudley Lane
    NE13 6BE Seaton Burn
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish72766290002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SEATON FOURTEEN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    D.F.W. Golding Limited
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    06 apr 2016
    Dudley Lane
    Seaton Burn
    NE13 6BE Newcastle Upon Tyne
    Seaton Burn House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Companies Registry
    Numero di registrazione1991200
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SEATON FOURTEEN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 ott 1989
    Consegnato il 02 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 475,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargees
    Brevi particolari
    F/H land and factory premises on the north east side of pool lane langley title no wr 5317.
    Persone aventi diritto
    • Jorden Production LTD
    • Hulbert Developments LTD
    Transazioni
    • 02 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 05 nov 1986
    Consegnato il 12 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land and premises north side of duke street sutton coalfield t/n wm 334934 floating charge all the undertaking goodwill assets and rights of the company present and future book or other debts goodwill see doc for fuller details.
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 12 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 ott 1986
    Consegnato il 09 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over land on the north east side of aldridge rd, streetley, walsall, W. midlands title no. Wm 353500 together with all buildings and fixtures goodwill and full benefit of any licences present & future.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Financial Services LTD
    Transazioni
    • 09 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 mag 1986
    Consegnato il 06 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or D.F.W. golding limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises north side of duke street, sutton coldfield, birmingham title no wm 334934 by way of floating charge all of the companys undertaking & goodwill & its property assets & rights (see doc 11 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Tcb Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 feb 1986
    Consegnato il 06 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land at fladbury hereford and worcester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1985
    Consegnato il 02 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land in rectory lane harvington hereford & worcester.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1985
    Consegnato il 02 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at fladbury hill fladbury hereford.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0