YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02066471
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    UPPERMINOR LIMITED22 ott 198622 ott 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 giu 2018

    6 pagineLIQ03

    Modifica dei dettagli di Tilney Group Limited come persona con controllo significativo il 27 gen 2017

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Tilney Bestinvest Group Limited come persona con controllo significativo il 07 dic 2016

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a 15 Canada Square London E14 5GL in data 18 lug 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 giu 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF England a 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 apr 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Cessazione della carica di John Robert Porteous come amministratore in data 28 feb 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Wadham St.John Downing come amministratore in data 21 feb 2017

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL in data 02 nov 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Rehana Hasan come segretario in data 31 ott 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Robert Alan Devey come amministratore in data 29 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Vernon Wright come amministratore in data 30 giu 2016

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL

    1 pagineAD04

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF

    1 pagineAD03

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2016

    Stato del capitale al 31 mar 2016

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Jacqueline Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL in data 31 mar 2016

    1 pagineAD01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2016 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HASAN, Rehana
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    217676460001
    DOWNING, Wadham St. John
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    Amministratore
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    EnglandBritish203301710001
    BELLAMY, Martin William
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Segretario
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    173986860001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    197500790001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    British26428410003
    JOHNSTON, Carol Ann
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    Segretario
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    British52538020003
    NICHOLS, Sarah
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British157100100001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Segretario
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    British129803720001
    BRADSHAW, Phillip Gordon
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26428400002
    BUSSEY, Michael Adrian
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish52554700003
    CHAPMAN, Andrew
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish39777190002
    COLEMAN, Lynn Rose
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish149721950001
    COONEY, Dominic Francis
    The Spinney
    WF2 6JN Wakefield
    15
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Spinney
    WF2 6JN Wakefield
    15
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish138563720001
    CRESSWELL-TURNER, Miles Marius
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish135272850001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    FLOWER, Gordon Mark
    Sovereign Fold
    HG5 0WJ Knaresborough
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sovereign Fold
    HG5 0WJ Knaresborough
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish133025980001
    FOX, Chay Munro
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish172112550001
    HAINES, Stephen Paul
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish185462290001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish26428410003
    HOGG, Andrew
    1 Park House Mill
    Renton Close Bishop Monkton
    HG3 1BW Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Park House Mill
    Renton Close Bishop Monkton
    HG3 1BW Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish63356910007
    JACOBS, Andrew Stephen
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish183659460001
    JOHNSTON, Carol Ann
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    Amministratore
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    British52538020002
    JONES, Gaius Trefor Griffith
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish57884740001
    JONES, Peter Francis
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33965180002
    MIDGLEY, Steven Richard
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish186658380001
    MULLORD, Kathleen Francis
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomSouth African160087800001
    NICHOLS, Sarah Elizabeth
    1 Home Farm Square
    Birstwith
    HG3 2WA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    1 Home Farm Square
    Birstwith
    HG3 2WA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish93464600001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Amministratore
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    EnglandBritish129803720001
    POLIN, Jonathan Charles
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    ScotlandBritish97840060003
    PORTEOUS, John Robert
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish166212270001
    SAWYER, Gareth Matthew
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    Amministratore
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    United KingdomBritish46468670003
    SUMMERELL, Paul
    11 Cricketers Fold
    Shadwell
    LS17 8WE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Cricketers Fold
    Shadwell
    LS17 8WE Leeds
    West Yorkshire
    British96162090001
    TAGLIABUE, Alfio
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Amministratore
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomItalian76352220004
    WRIGHT, Paul Vernon
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish137936580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    17th Floor
    6 New Street Square, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    Towry Group
    England
    England
    06 apr 2016
    17th Floor
    6 New Street Square, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    Towry Group
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04126418
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of debts by way of security
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 19 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All future rights title and interest and benefits in the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over cash deposit
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 16 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit and all the present and future rights titles and benefit of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of debts by way of security
    Creato il 29 set 2004
    Consegnato il 15 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or yorkshire investment group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First priority assignment all present and future rights,titles and interest in and benefits of the company in the debts,together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 ott 2002
    Consegnato il 17 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture deed
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 06 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 mar 2019Data di scioglimento
    21 giu 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0