NPS (UK4) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNPS (UK4) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02149536
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NPS (UK4) LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova NPS (UK4) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NPS (UK4) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NORTHGATE LAND AND PROPERTY SOLUTIONS LIMITED01 dic 200501 dic 2005
    M V M CONSULTANTS PLC11 set 198711 set 1987
    TRYVISION LIMITED22 lug 198722 lug 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di NPS (UK4) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per NPS (UK4) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 mag 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 apr 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018

    2 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 apr 2017, non revisionato

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    4 pagineAA

    Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ago 2015

    Stato del capitale al 08 ago 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed northgate land and property solutions LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name16 giu 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 09 giu 2015

    RES15

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    4 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di David John Meaden come amministratore in data 22 dic 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di NPS (UK4) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201347710052
    BENNETT, Colston Albert, Company Secretary
    18 Station Road
    Backwell
    BS19 3NW Bristol
    Avon
    Segretario
    18 Station Road
    Backwell
    BS19 3NW Bristol
    Avon
    British17444890001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    GOLLOP, Philip George
    259 Passage Road
    Brentry
    BS10 7JA Bristol
    Avon
    Segretario
    259 Passage Road
    Brentry
    BS10 7JA Bristol
    Avon
    British944510001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding 2
    Peoplebuilding Estate Maylands
    HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Peoplebuilding 2
    Peoplebuilding Estate Maylands
    HP2 4NW Avenue Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    YOUNG, Victor John
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    Segretario
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    British23808250002
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanDirector165900220001
    CHESTER, Andrew, Dr
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    Amministratore
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    BritishCompany Director36723830001
    CLIFTON, Philip John
    The Dovecote
    Church Street
    LE15 8JR North Luffenham
    Rutland
    Amministratore
    The Dovecote
    Church Street
    LE15 8JR North Luffenham
    Rutland
    BritishDirector60585520003
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director237260100001
    GLEAVE, David
    4 Cricklade Road
    BS7 9EN Bristol
    S Gloucestershire
    Amministratore
    4 Cricklade Road
    BS7 9EN Bristol
    S Gloucestershire
    BritishComputer Consultant30628010004
    GREENLAND, Martyn Geoffrey
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishCompany Director45440250001
    HARLEY, Donald Wilson George
    22 Saint Marys Park
    SG8 7XB Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Saint Marys Park
    SG8 7XB Royston
    Hertfordshire
    BritishFinance Director80358920001
    MACHIN, Brian Roy
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    Amministratore
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    BritishDirector8982230003
    MARKHAM, Richard John
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Amministratore
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    United KingdomBritishDirector35544120002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector199843940001
    PARRY, Leslie
    2 Millers Cottages
    Fromebridge Lane
    GL2 7PD Whitminster
    Gloucestershire
    Amministratore
    2 Millers Cottages
    Fromebridge Lane
    GL2 7PD Whitminster
    Gloucestershire
    BritishGroup Marketing Director36362110004
    PAVELEY, Norman
    21 Newfield Road
    Hagley
    DY9 0JP Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    21 Newfield Road
    Hagley
    DY9 0JP Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector28026460001
    RIX, David
    Upper Coach House Saville Road
    BS6 7TS Bristol
    Amministratore
    Upper Coach House Saville Road
    BS6 7TS Bristol
    BritishCompany Director56402040001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector66955690003
    VENN, Jon
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    Amministratore
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    BritishDirector15778460001
    YOUNG, Victor John
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    BritishProject Manager23808250002

    Chi sono le persone con controllo significativo di NPS (UK4) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England And Wales)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03033447
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NPS (UK4) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 29 apr 2008
    Consegnato il 12 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 12 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2008
    • 09 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 11 mag 2007
    Consegnato il 23 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Facility Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 lug 1992
    Consegnato il 15 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 set 1988
    Consegnato il 28 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    13 great george street bristol, avon title no. AV103404, AV5629 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 ott 1987
    Consegnato il 20 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sums standing to the credit in the deposit account held at dryfield finance limited of 2 st pauls road, clifton bristol opened by the chargees solicitor in accordance with the terms of the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Investment and Capital Grousth PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NPS (UK4) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 apr 2019Inizio della liquidazione
    21 lug 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0