MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED

MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02157370
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED29 feb 198829 feb 1988
    BURGINHALL 194 LIMITED26 ago 198726 ago 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 mag 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 apr 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018

    2 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2017

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    4 pagineAA

    Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2016

    Stato del capitale al 01 giu 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 giu 2015

    Stato del capitale al 29 giu 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    4 pagineAA

    Nomina di David John Meaden come amministratore in data 22 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Pinsent Masons Secretarial Limited come segretario in data 22 dic 2014

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di John Robert Stier come amministratore in data 22 dic 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    Segretario
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    YOUNG, Victor John
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    Segretario
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    British23808250002
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    CHESTER, Andrew, Dr
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    Amministratore
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    British36723830001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GREENLAND, Martyn Geoffrey
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British45440250001
    MACHIN, Brian Roy
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    Amministratore
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    British8982230003
    MARKHAM, Richard John
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Amministratore
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    United KingdomBritish35544120002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    RUDD, Jeremy George Winterton
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    Amministratore
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    United KingdomBritish74891640002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    VENN, Jon
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    Amministratore
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    British15778460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03033447
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 26 set 1997
    Consegnato il 02 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 15 mag 1995
    Consegnato il 16 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the obligations undertakings and liabilities of the company to the chargee (as defined in a charge dated 21ST october 1988)
    Brevi particolari
    Pursuant to clause 2 if the charge (as amended by the deed of variation) all right title & interest in the local authority agreement & in the settlement agreement but without limitation the benefit of all powers & remedies but excluding all amounts payable thereunder in respect of vat. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed (amending the charge dated 20TH july 1988 and the supplemental charge dated 18TH november 1991)
    Creato il 12 mag 1994
    Consegnato il 14 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    And amending the charge dated 20TH july 1988 (the "general clc charge") and the supplemental charge dated 18TH november 1991 (the "supplemental charge")
    Brevi particolari
    (I) first fixed charge all clc's right title and interest in each of the deposits (ii) first fixed charge all clc's right title and interest in the digital agreement (iii) first fixed charge all clc's right title and interest in the csl agreement (iv) floating charge all undertaking property assets and rights....... See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 mag 1993
    Consegnato il 21 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the local authority agreement including the benefit of all powers and remedies for enforcing the same but excluding all amounts payable to the company thereunder in respect of V.A.T.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Specific digital security
    Creato il 13 mag 1993
    Consegnato il 21 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and/or this deed
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all the machinery equipment and other chattels as listed on the form 395 inclusive of clc gateway and one VT320 terminal and keyboard. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transazioni
    • 21 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 dic 1992
    Consegnato il 05 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and in relation to or in connection with the advance (as defined therein) and other monies due in respect thereof
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge clc's right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395 and schedule attached.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over contract
    Creato il 04 nov 1992
    Consegnato il 19 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that benefit of an agreement dated 10/4/90 between the company and hartlepool borough council.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Specific digital security
    Creato il 13 ott 1992
    Consegnato il 26 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity as defined therein
    Brevi particolari
    First fixed charge all right title and interest of the company in the equipment as detailed on form 395 see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transazioni
    • 26 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 ott 1992
    Consegnato il 20 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of thw charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 apr 1992
    Consegnato il 06 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined) and/or this charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in the local authority agreement (as defined) ....(please see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 mar 1992
    Consegnato il 24 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC in connection with the advance (as defined) and/or this charge.
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge, clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined). (See doc 395 reference M8L for full details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Specific digital security
    Creato il 25 feb 1992
    Consegnato il 09 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity contained in clause 5 of the clc digital agreement dated 25/7/89
    Brevi particolari
    1 oracle database licence and various items of equipment see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transazioni
    • 09 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 17 feb 1992
    Consegnato il 22 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 20 dic 1991
    Consegnato il 07 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC in relation to the advance applicable to hereford city council under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All right, title and interest in the local authority agreement (please see doc M395 reference M247 for full details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 18 nov 1991
    Consegnato il 29 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of second fixed charge ,clc's right title and interest in each of the deposits ,the digital agreement,the csl agreement. Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 set 1991
    Consegnato il 12 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined)
    Brevi particolari
    All the company's interest in and to the local authority agreement (please see form 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 25 lug 1991
    Consegnato il 01 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the 'advance' this charge as defined
    Brevi particolari
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge C.L.c's right title and interest in the local authority agreement. As defined on form 395 M9.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 25 lug 1991
    Consegnato il 01 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the "advance" this charge as defined.
    Brevi particolari
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole, absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined on the form 395 M10).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Specific digital security.
    Creato il 08 mag 1991
    Consegnato il 28 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and this charge.
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in the equipment specified on form M395 (see form M395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transazioni
    • 28 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 mag 1991
    Consegnato il 10 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance and all other moneys due in respect thereof under the terms of the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority. Agreement (for full details see form 395 & schedule detailed).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 16 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Specific digital security
    Creato il 16 apr 1991
    Consegnato il 27 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    Brevi particolari
    (See 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • Digital Equipment Co. Limited.
    Transazioni
    • 27 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Specific digital security
    Creato il 16 apr 1991
    Consegnato il 27 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    Brevi particolari
    (See 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • Digital Equipment Co. Limited.
    Transazioni
    • 27 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 apr 1991
    Consegnato il 26 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 apr 1991
    Consegnato il 26 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 09 gen 1991
    Consegnato il 23 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 apr 2019Inizio della liquidazione
    01 feb 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0