B B PLANT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàB B PLANT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02208086
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di B B PLANT LIMITED?

    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova B B PLANT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di B B PLANT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KASS PLANT LIMITED24 dic 198724 dic 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di B B PLANT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per B B PLANT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Max share restriction deleted 31/05/2013
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 mag 2013

    • Capitale: GBP 436,048
    5 pagineSH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Nomina di John William Young Strachan Samuel come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di B B PLANT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Segretario
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Amministratore
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritish3909060002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Segretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Segretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    EVANS, Clifford Stuart
    8 Myrtle Road
    MK42 0QT Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    8 Myrtle Road
    MK42 0QT Bedford
    Bedfordshire
    British40039730001
    KEANE, Simon Andrew
    9 Birchdale
    DN18 5ED Barton On Humber
    South Humberside
    Segretario
    9 Birchdale
    DN18 5ED Barton On Humber
    South Humberside
    British68502540001
    MCDONOUGH, Paul, Director
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    Segretario
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    British9561800001
    STEANE, Nigel Brian
    2 Roseberry Gardens
    Hucknall
    NG15 7PX Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    2 Roseberry Gardens
    Hucknall
    NG15 7PX Nottingham
    Nottinghamshire
    British27620980001
    STEANE, Nigel Brian
    2 Roseberry Gardens
    Hucknall
    NG15 7PX Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    2 Roseberry Gardens
    Hucknall
    NG15 7PX Nottingham
    Nottinghamshire
    British27620980001
    WARD, Elizabeth Anne
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British32157210001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish61631390001
    CREASEY, Robert Peter
    1 Park View Helford
    Park View Messingham
    DN17 3TT Scunthorpe
    South Humberside
    Amministratore
    1 Park View Helford
    Park View Messingham
    DN17 3TT Scunthorpe
    South Humberside
    British49772640001
    DAY, Simon Philip
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish71393050001
    HALL, Graham
    Walls Farm Stoughton Road
    Stoughton
    BS28 4PP Wedmore
    Somerset
    Amministratore
    Walls Farm Stoughton Road
    Stoughton
    BS28 4PP Wedmore
    Somerset
    British57562800001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Amministratore
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritish87102720001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    MCDONOUGH, Paul, Director
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    Amministratore
    16 Low Road
    Worlaby
    DN20 0LX Brigg
    South Humberside
    United KingdomBritish9561800001
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    British1729130003
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Amministratore
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    British51937070001
    MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    41291250009

    B B PLANT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 02 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-land at middleplatt road immingham humberside t/n-HS216414 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including registrations viz:.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 mar 1988
    Consegnato il 29 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncaleld capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1988Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0