WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED

WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02271092
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    31 Hill Street
    W1J 5LS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INKWISE LIMITED24 giu 198824 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 022710920012 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920016 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920014 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 022710920017, creata il 27 gen 2021

    34 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022710920016, creata il 27 gen 2021

    37 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 022710920009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022710920011 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 022710920015, creata il 17 feb 2020

    35 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022710920014, creata il 17 feb 2020

    38 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 022710920012, creata il 21 set 2018

    35 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022710920013, creata il 21 set 2018

    36 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FORSTERS SECRETARIES LTD
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Segretario
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione3589800
    192936360001
    LAI, Robert
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    ChinaChinese248063590001
    RUAYRUNGRUANG, Woraphanit
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    ChinaThai192235480001
    COOK, Kenneth Alan
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    Segretario
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    British100000003
    OSBORNE, Ian
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    Segretario
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    British44830690006
    OGIER CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED
    Third Floor
    Equitable House, 47 King William Street
    EC4R 9JD London
    Segretario
    Third Floor
    Equitable House, 47 King William Street
    EC4R 9JD London
    121915660001
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Segretario
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    REIGNWOOD INVESTMENTS UK LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    5th Floor 4
    Segretario
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    5th Floor 4
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione08346375
    191703150001
    BEGG, Peter Francis Cargill
    3 St Margarets Crescent
    SW15 6HL London
    Amministratore
    3 St Margarets Crescent
    SW15 6HL London
    United KingdomBritish24097610001
    BERNERD, Elliott
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    Amministratore
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    British44790970001
    BROKE, Michael Haviland Adlington
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    Amministratore
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    British2996750001
    BUTLER, Robin Elliott
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritish2996760007
    CARING, Richard Allan
    Spaniards Field
    Wildwood Rise Hampstead
    NW11 6SX London
    Amministratore
    Spaniards Field
    Wildwood Rise Hampstead
    NW11 6SX London
    EnglandBritish66036600003
    DONALDSON, John
    Hedgerows 15 Greenways Drive
    Sunningdale
    SL5 9QS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Hedgerows 15 Greenways Drive
    Sunningdale
    SL5 9QS Ascot
    Berkshire
    Great BritainBritish113377520001
    GEGEN BAUER, Willy Benedict
    6 Hitherwood Drive
    Dulwich
    SE19 1XB London
    Amministratore
    6 Hitherwood Drive
    Dulwich
    SE19 1XB London
    British & German47894810001
    GRABINER, Anthony, Lord
    1 Essex Court
    Temple
    EC4Y 9AR London
    Amministratore
    1 Essex Court
    Temple
    EC4Y 9AR London
    United KingdomBritish82276320001
    HIJIKURO, Shinichiro
    6 Clayton House
    50 Trinity Church Road
    SW13 8EL London
    Amministratore
    6 Clayton House
    50 Trinity Church Road
    SW13 8EL London
    Japanese48575190003
    HOWLAND-JACKSON, John David
    Teh Old Rectory
    Loxhill
    GU8 4BQ Hascombe
    Surrey
    Amministratore
    Teh Old Rectory
    Loxhill
    GU8 4BQ Hascombe
    Surrey
    British34051640004
    HUGILL, William Nigel
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    Amministratore
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    EnglandBritish3015960006
    LAWRENCE, James Wyndham Stuart
    169 Oatland Drive
    KT13 9JY Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    169 Oatland Drive
    KT13 9JY Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish101106300003
    LLOYD HUGHES, Timothy John Clive
    83 Ravenscourt Road
    W6 0UJ London
    Amministratore
    83 Ravenscourt Road
    W6 0UJ London
    British33742260001
    MASAYASU, Tadao
    Flat 13-2
    64 Buckingham Gate
    SW1 London
    Amministratore
    Flat 13-2
    64 Buckingham Gate
    SW1 London
    Japanese38896420001
    MORRIS, Guy Christopher Ronald
    World Business Centre 2
    Newall Road
    TW6 2SF London Heathrow Airport
    Arora Holdings Limited
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    World Business Centre 2
    Newall Road
    TW6 2SF London Heathrow Airport
    Arora Holdings Limited
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritish104547160001
    MORRIS, Guy Christopher Ronald
    14 Shefford Crescent
    RG40 1YP Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    14 Shefford Crescent
    RG40 1YP Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish104547160001
    NAKAJIMA, Hirokazu
    11-8 64 Buckingham Gate
    Westminster
    SW1 London
    Amministratore
    11-8 64 Buckingham Gate
    Westminster
    SW1 London
    Japanese32421790001
    NI, Songhua
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    United KingdomChinese189850960001
    OAKLEY, David John Philip
    54 Inner Park Road
    SW19 6DA London
    Amministratore
    54 Inner Park Road
    SW19 6DA London
    British71494250002
    PHILLIPS, David
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Amministratore
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    United KingdomBritish65062400001
    RUSYRUNGRUANG, Chanchai, Dr
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    ChinaThai191702640001
    SHAH, Selim Jehan
    Holt House
    Blakeley Lane
    WA16 7LP Mobberley
    Cheshire
    Amministratore
    Holt House
    Blakeley Lane
    WA16 7LP Mobberley
    Cheshire
    British2703280001
    SHEPARD, Giles Richard Carless
    Wallop House
    Nether Wallop
    SO20 8HE Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Wallop House
    Nether Wallop
    SO20 8HE Stockbridge
    Hampshire
    British3015990001
    SHIMIZU, Tsutomu
    Flat 4 87
    St Johns Wood
    NW8 9QX London
    Amministratore
    Flat 4 87
    St Johns Wood
    NW8 9QX London
    Japanese33184170001
    SMALL, Julian David Stanley
    Heathpark Drive
    GU20 6JA Windlesham
    43
    Surrey
    Amministratore
    Heathpark Drive
    GU20 6JA Windlesham
    43
    Surrey
    United KingdomBritish63245510002
    TAKI, Shigeru
    73 Blair Court
    2 Boundary Road
    NW11 6NT London
    Amministratore
    73 Blair Court
    2 Boundary Road
    NW11 6NT London
    Japanese52596140001
    TENZER, Michael Alan
    7 Parkmead Gardens
    NW7 2JW London
    Amministratore
    7 Parkmead Gardens
    NW7 2JW London
    United KingdomBritish103323170001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    England
    06 apr 2016
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05455442
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    England
    06 apr 2016
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02271790
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.

    WENTWORTH GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 gen 2021
    Consegnato il 01 feb 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited
    Transazioni
    • 01 feb 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 gen 2021
    Consegnato il 01 feb 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited
    Transazioni
    • 01 feb 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 feb 2020
    Consegnato il 24 feb 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 24 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 feb 2020
    Consegnato il 24 feb 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 24 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 set 2018
    Consegnato il 25 set 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 25 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 set 2018
    Consegnato il 25 set 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 25 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2016
    Consegnato il 19 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 19 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2016
    Consegnato il 19 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 19 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 set 2014
    Consegnato il 09 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 09 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 set 2014
    Consegnato il 09 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 09 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 ott 2011
    Consegnato il 27 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of actual properties charged, please refer to the form MG01); fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set off agreement
    Creato il 03 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of the account or accounts.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land and buildings k/a warren lodge wellington avenue wentworth virginia water surrey runnymeade t/n SY653439, land at wentworth virginia water surrey t/n SY588740 and land k/a elm court station parade virginia water t/n SY478639. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 16 dic 1996
    Consegnato il 03 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being bagshott lodge and the gate house all present and future book debts by way of assignment the goodwill of the business if any see form 395 for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of rights
    Creato il 16 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest of the mortgagor in and under each of the contracts and the full benefit of each of the contracts as defined in the schedule to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of rights
    Creato il 30 giu 1992
    Consegnato il 13 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 30 june 1992
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the mortgagor in and under each of the contracts and other documents (see form 395 and contd sheets for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 giu 1992
    Consegnato il 13 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bagshott lodge, surrey t/n-SY597889 and gate house, suurey. T/n-SY498721 and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0