ISG INTERIOR LIMITED

ISG INTERIOR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISG INTERIOR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02510874
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISG INTERIOR LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ISG INTERIOR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o ISG PLC
    Aldgate House
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISG INTERIOR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ISG FIT OUT LIMITED17 giu 201117 giu 2011
    ISG DEAN AND BOWES LIMITED01 lug 200801 lug 2008
    ISG DEAN & BOWES LIMITED13 lug 200613 lug 2006
    DEAN & BOWES LIMITED20 mar 199220 mar 1992
    TARBOOSH LIMITED12 giu 199012 giu 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISG INTERIOR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ISG INTERIOR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Helen Gaye Cowing come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 giu 2016

    Stato del capitale al 13 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Helen Gaye Cowing il 01 mar 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Paul Martin Cossell come amministratore in data 06 giu 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Stockton il 20 mag 2016

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Samuel David Lawther come amministratore in data 29 apr 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Stockton come amministratore in data 20 mag 2016

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Helen Gaye Cowing il 01 mar 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Helen Gaye Cowing come amministratore in data 01 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Charles Bennett Houlton come amministratore in data 01 mar 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 giu 2015

    Stato del capitale al 08 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 giu 2014

    Stato del capitale al 06 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Interior Services Group Plc Aldgate House 33 Aldgate High Street London EC3N 1AG* in data 06 giu 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di ISG INTERIOR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRANNEY, Jared Stephen Philip
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    Segretario
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    British74806700006
    COSSELL, Paul Martin
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    Amministratore
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    EnglandBritishDirector64007780003
    STOCKTON, Mark
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    Amministratore
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United KingdomBritishAccountant152719980001
    CAREY, Peter
    17 High Street
    Little Shelford
    CB2 5ES Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    17 High Street
    Little Shelford
    CB2 5ES Cambridge
    Cambridgeshire
    IrishChartered Accountant108763620001
    FITZSIMONS, Gerard
    19 Victoria Park
    CB4 3EJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario nominato
    19 Victoria Park
    CB4 3EJ Cambridge
    Cambridgeshire
    British900008000001
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Segretario
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    BritishAccountant97375340001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Huntington Crescent
    Headingley
    LS16 5RT Leeds
    Segretario
    2 Huntington Crescent
    Headingley
    LS16 5RT Leeds
    British52221890003
    SAXTON, Peter William Harley
    Ducklake House Springhead
    Ashwell
    SG7 5LL Baldock
    Herts
    Segretario
    Ducklake House Springhead
    Ashwell
    SG7 5LL Baldock
    Herts
    BritishChartered Accountant6830250003
    ANDERSON, John Ireland
    15 Woolston Avenue
    SG6 2ED Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 Woolston Avenue
    SG6 2ED Letchworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director53079380002
    BIRD, Michael
    17 Hill Rise
    St Ives
    PE27 6SP Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 Hill Rise
    St Ives
    PE27 6SP Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishAccountant109829550001
    BISHOP, David John
    Flat 3b Ratcliffe Wharf
    18-22 Narrow Street
    E14 8DQ London
    Amministratore
    Flat 3b Ratcliffe Wharf
    18-22 Narrow Street
    E14 8DQ London
    BritishBuilding Contractor22571190002
    BOCK, Christopher Nigel
    Minnickfold Cottage
    Anstie Lane, Coldharbour
    RH5 4LP Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Minnickfold Cottage
    Anstie Lane, Coldharbour
    RH5 4LP Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director77209350001
    BRIERLEY, Philip
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCompany Director54808010001
    CAREY, Peter
    17 High Street
    Little Shelford
    CB2 5ES Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 High Street
    Little Shelford
    CB2 5ES Cambridge
    Cambridgeshire
    IrishChartered Accountant108763620001
    CLARK, Duncan Robert
    Green Farm House
    The Green Colne Engaine
    CO6 2EZ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Green Farm House
    The Green Colne Engaine
    CO6 2EZ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishDirector98591180001
    COWING, Helen Gaye
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    Amministratore
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    EnglandBritishDirector180279040001
    DEAN, Stephen
    311 Portland House
    Glacis Road
    FOREIGN Gibraltar
    Amministratore
    311 Portland House
    Glacis Road
    FOREIGN Gibraltar
    BritishManaging Director76827800002
    DUFFY, Paul Robert
    Orchard Way
    Lower Cambourne
    CB23 6BN Cambridge
    31
    Amministratore
    Orchard Way
    Lower Cambourne
    CB23 6BN Cambridge
    31
    EnglandBritishCompany Director147469560001
    FITZSIMONS, Gerard
    19 Victoria Park
    CB4 3EJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore delegato nominato
    19 Victoria Park
    CB4 3EJ Cambridge
    Cambridgeshire
    British900008000001
    HOGG, Christopher
    Inglenook
    46 Warren Road
    SS9 3TS Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    Inglenook
    46 Warren Road
    SS9 3TS Leigh On Sea
    Essex
    BritishDirector88890550001
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    EnglandBritishAccountant97375340001
    HOULTON, Jonathan Charles Bennett
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    Amministratore
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    United KingdomBritishDirector70905760002
    JACKSON, David James
    41 Norwood Park
    Birkby
    HD2 2DU Huddersfield
    Yorkshire
    Amministratore
    41 Norwood Park
    Birkby
    HD2 2DU Huddersfield
    Yorkshire
    BritishCompany Director62867720001
    JACKSON, David James
    41 Norwood Park
    Birkby
    HD2 2DU Huddersfield
    Yorkshire
    Amministratore
    41 Norwood Park
    Birkby
    HD2 2DU Huddersfield
    Yorkshire
    BritishDirector62867720001
    JONES, Richard James
    Stonegarth
    Beech Lane
    HG3 1AN Spofforth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Stonegarth
    Beech Lane
    HG3 1AN Spofforth
    West Yorkshire
    BritishDirector78917370001
    LAWTHER, Samuel David
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    Amministratore
    c/o Isg Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    England
    EnglandBritishCompany Director154579210001
    PARKER, James Robert
    27 Henson Grove
    Timperley
    WA15 7QA Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    27 Henson Grove
    Timperley
    WA15 7QA Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishQuantity Surveyor42217400004
    SAXTON, Peter William Harley
    Ducklake House Springhead
    Ashwell
    SG7 5LL Baldock
    Herts
    Amministratore
    Ducklake House Springhead
    Ashwell
    SG7 5LL Baldock
    Herts
    United KingdomBritishChartered Accountant6830250003
    SONES, Gary
    Kingfischer House
    Meadow Lane
    NN14 4EH Denford
    Northamptonshire
    Amministratore
    Kingfischer House
    Meadow Lane
    NN14 4EH Denford
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director98900360001
    STONES, David
    3 Tapwoods
    CO3 3TJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    3 Tapwoods
    CO3 3TJ Colchester
    Essex
    BritishDirector17351620001
    WOMACK, Michael Thomas
    12 De Freville Avenue
    CB4 1HR Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore delegato nominato
    12 De Freville Avenue
    CB4 1HR Cambridge
    Cambridgeshire
    British900007990001

    ISG INTERIOR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 mag 2007
    Consegnato il 01 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 set 2005
    Consegnato il 11 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the funders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 11 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 gen 2003
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities in any manner whatsoever due or to become due from the company to the senior lenders,mezzanine lenders,investor lenders and working capital bank under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 1993
    Consegnato il 10 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 mag 1992
    Consegnato il 02 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank LTD
    Transazioni
    • 02 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0