TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02587396 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cast House Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TRAVELLERS PROTECTION SERVICES LIMITED | 20 set 1994 | 20 set 1994 |
| GRAND UK INSURANCE SERVICES LIMITED | 01 mar 1991 | 01 mar 1991 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mrs Penny Fullerton come segretario in data 24 mar 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Blott come segretario in data 24 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Peter John Hubbard come amministratore in data 29 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Blott come segretario in data 01 nov 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Christopher Orton come segretario in data 01 nov 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Warren come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Warren come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeffrey Christopher Orton come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Penelope Fullerton come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Ryan Mark Gill come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Penelope Jane Fullerton come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stacey Zaczkiewicz come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLERTON, Penny | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 206865730001 | |||||||
| BEALES, Karen Anne | Amministratore | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | 135540180002 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184068890001 | |||||
| SMITH, Malachy Paul | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | Ireland | Irish | 262619320001 | |||||
| BLOOM, Colin Preston Paul | Segretario | 27 Woodfields Stradbroke IP21 5JQ Eye Suffolk | British | 21182260001 | ||||||
| BLOTT, Stephen | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 202286490001 | |||||||
| BLOTT, Stephen | Segretario | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184069960001 | |||||||
| LAWRENCE, Christopher | Segretario | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 185565520001 | |||||||
| THORLEY, Anne | Segretario | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Segretario | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Segretario | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 170325190001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED | Segretario | 10 King William Street EC4N 7TW London | 107712310001 | |||||||
| ASPROU, Caroline Anna | Amministratore | Highnoon Woodbastwick Road, Blofield Heath NR13 4QH Norwich Norfolk | British | 76073630001 | ||||||
| BELL, Graeme Paul | Amministratore | 6 Moule Rise LS25 2PH Garforth West Yorkshire | England | British | 100163980001 | |||||
| CAMM, Suzanne Mary | Amministratore | The Old Coach House Norwich Road Reepham NR10 4JN Norwich Norfolk | British | 80914120002 | ||||||
| FRANCIS, Timothy John | Amministratore | Farm End Topcroft NR35 2BB Bungay Norfolk | British | 80914650001 | ||||||
| HARNBY, Alastair John | Amministratore | Dene Bank BD16 4AR Bingley 21 West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 172070220002 | |||||
| HUBBARD, Peter John | Amministratore | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 28375870003 | |||||
| JAMES, Philip William Henry | Amministratore | Hampton Head 9 Peppercorn Lane Southampton Sn 04 Bermuda | England | British | 33901640008 | |||||
| LAIRD, Oliver Walter | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | 233726140001 | |||||
| LAWRENCE, Christopher | Amministratore | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| MARLEY, Nicholas James | Amministratore | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | 113304050001 | |||||
| MCGUIRE, Elisabeth Mary | Amministratore | 3 Landfall House Springvale PO34 5AN Seaview Isle Of Wight | British | 80914390001 | ||||||
| MEDDES, Kenneth Sydney | Amministratore | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | United Kingdom | British | 11486330002 | |||||
| NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir | Amministratore | 1 Pipers Close CH60 9LJ Heswall Merseyside | United Kingdom | British | 85618250001 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Amministratore | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| RIVETT, Paul Geoffrey Leo | Amministratore | Westfield Place Whinburgh Road, Westfield NR19 1QJ Dereham Norfolk | British | 67188630001 | ||||||
| ROLFE, Timothy Paul | Amministratore | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | 107872640001 | |||||
| SMITH, Paul Kenneth | Amministratore | 4 Merchant Exchange Bridge Street YO1 6LT York North Yorkshire | United Kingdom | British | 126031290001 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Amministratore | 2 Knoll Road RH4 3EW Dorking Surrey | United Kingdom | British | 77794000002 | |||||
| THORLEY, Anne | Amministratore | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk General Insurance Limited | 06 apr 2016 | Gibraltar Island Road Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 28 feb 2007 Consegnato il 15 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of deposit | Creato il 24 dic 2004 Consegnato il 31 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Deposit initially of £50,000 credited to account designation 68126255 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0