TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED

TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02587396
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cast House Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRAVELLERS PROTECTION SERVICES LIMITED20 set 199420 set 1994
    GRAND UK INSURANCE SERVICES LIMITED01 mar 199101 mar 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    2 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mrs Penny Fullerton come segretario in data 24 mar 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stephen Blott come segretario in data 24 mar 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2016

    Stato del capitale al 09 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Peter John Hubbard come amministratore in data 29 feb 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Blott come segretario in data 01 nov 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jeffrey Christopher Orton come segretario in data 01 nov 2015

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mar 2015

    Stato del capitale al 10 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mar 2014

    Stato del capitale al 05 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Michael Warren come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Warren come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jeffrey Christopher Orton come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Penelope Fullerton come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ryan Mark Gill come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Penelope Jane Fullerton come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stacey Zaczkiewicz come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FULLERTON, Penny
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    206865730001
    BEALES, Karen Anne
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    Amministratore
    Marling Road
    Ainley Top
    HD2 2EE Huddersfield
    The Chalet
    Uk
    EnglandBritish135540180002
    GILL, Ryan Mark
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    EnglandBritish184068890001
    SMITH, Malachy Paul
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    IrelandIrish262619320001
    BLOOM, Colin Preston Paul
    27 Woodfields
    Stradbroke
    IP21 5JQ Eye
    Suffolk
    Segretario
    27 Woodfields
    Stradbroke
    IP21 5JQ Eye
    Suffolk
    British21182260001
    BLOTT, Stephen
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    202286490001
    BLOTT, Stephen
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Low Wood
    Wilsden
    BD15 0JS Bradford
    30
    West Yorkshire
    England
    British139352410001
    FULLERTON, Penelope Jane
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    184069960001
    LAWRENCE, Christopher
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    Segretario
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    British90712300001
    ORTON, Jeffrey Christopher
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    185565520001
    THORLEY, Anne
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    Segretario
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    British26486150002
    WARMAN, Paul Jonathan
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    Segretario
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    British25255550003
    WARMAN, Paul Jonathan
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    Segretario
    The Old Rectory
    Horsey
    NR29 4EF Great Yarmouth
    Norfolk
    British25255550003
    ZACZKIEWICZ, Stacey
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Segretario
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    170325190001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    Segretario
    10 King William Street
    EC4N 7TW London
    107712310001
    ASPROU, Caroline Anna
    Highnoon
    Woodbastwick Road, Blofield Heath
    NR13 4QH Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Highnoon
    Woodbastwick Road, Blofield Heath
    NR13 4QH Norwich
    Norfolk
    British76073630001
    BELL, Graeme Paul
    6 Moule Rise
    LS25 2PH Garforth
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Moule Rise
    LS25 2PH Garforth
    West Yorkshire
    EnglandBritish100163980001
    CAMM, Suzanne Mary
    The Old Coach House
    Norwich Road Reepham
    NR10 4JN Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    The Old Coach House
    Norwich Road Reepham
    NR10 4JN Norwich
    Norfolk
    British80914120002
    FRANCIS, Timothy John
    Farm End
    Topcroft
    NR35 2BB Bungay
    Norfolk
    Amministratore
    Farm End
    Topcroft
    NR35 2BB Bungay
    Norfolk
    British80914650001
    HARNBY, Alastair John
    Dene Bank
    BD16 4AR Bingley
    21
    West Yorkshire
    Uk
    Amministratore
    Dene Bank
    BD16 4AR Bingley
    21
    West Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritish172070220002
    HUBBARD, Peter John
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sevenleaze Lane
    Edge
    GL6 6NL Stroud
    Huddaknoll House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish28375870003
    JAMES, Philip William Henry
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    Amministratore
    Hampton Head
    9 Peppercorn Lane
    Southampton
    Sn 04
    Bermuda
    EnglandBritish33901640008
    LAIRD, Oliver Walter
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Old Mill Business Park
    Gibraltar Island Road
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish233726140001
    LAWRENCE, Christopher
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    Amministratore
    Dunelm House 47b The Street
    NR13 5AA Brundall
    Norfolk
    British90712300001
    MARLEY, Nicholas James
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    Amministratore
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    United KingdomBritish113304050001
    MCGUIRE, Elisabeth Mary
    3 Landfall House
    Springvale
    PO34 5AN Seaview
    Isle Of Wight
    Amministratore
    3 Landfall House
    Springvale
    PO34 5AN Seaview
    Isle Of Wight
    British80914390001
    MEDDES, Kenneth Sydney
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    Amministratore
    Hillside Townhill
    Bramham
    LS23 6QD Wetherby
    United KingdomBritish11486330002
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    Amministratore
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001
    POSNER, Howard Michael
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    Amministratore
    Stocks Lane
    HX2 6PR Luddenden
    Eaves House
    Halifax
    United KingdomBritish139631580001
    RIVETT, Paul Geoffrey Leo
    Westfield Place
    Whinburgh Road, Westfield
    NR19 1QJ Dereham
    Norfolk
    Amministratore
    Westfield Place
    Whinburgh Road, Westfield
    NR19 1QJ Dereham
    Norfolk
    British67188630001
    ROLFE, Timothy Paul
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    9 Overhill
    CR6 9JR Warlingham
    Surrey
    EnglandBritish107872640001
    SMITH, Paul Kenneth
    4 Merchant Exchange
    Bridge Street
    YO1 6LT York
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Merchant Exchange
    Bridge Street
    YO1 6LT York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish126031290001
    SMYTH, Timothy John
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    Amministratore
    2 Knoll Road
    RH4 3EW Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish77794000002
    THORLEY, Anne
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    Amministratore
    51 Mill Lane
    NR17 2NW Attleborough
    Norfolk
    British26486150002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gibraltar Island Road
    Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    06 apr 2016
    Gibraltar Island Road
    Old Mill Business Park
    LS10 1RJ Leeds
    Cast House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04506493
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 15 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse,London Branch
    Transazioni
    • 15 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 24 dic 2004
    Consegnato il 31 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deposit initially of £50,000 credited to account designation 68126255 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0