BB & EA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBB & EA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02702539
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BB & EA LIMITED?

    • (4525) /
    • (4550) /

    Dove si trova BB & EA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Chartford House
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BB & EA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOVCO 452 LIMITED31 mar 199231 mar 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di BB & EA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per BB & EA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 13 ago 2010

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagineLQ02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 lug 2010

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria di revoca della liquidazione

    1 pagineOCRESCIND

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 09 lug 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Renew Corporate Director Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Cessazione della carica di David Goodby come amministratore

    2 pagineTM01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 04 set 2009

    2 pagine3.6

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 04 set 2008

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di BB & EA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Lovell House
    616 Chiswick High Road
    W4 5RX London
    Segretario
    Lovell House
    616 Chiswick High Road
    W4 5RX London
    41291250013
    CARLISLE, Edward
    Unit 4b Interchange
    25 Business Park Bostocks Lane
    NG10 5QG Sandiacre
    Nottingham
    Amministratore
    Unit 4b Interchange
    25 Business Park Bostocks Lane
    NG10 5QG Sandiacre
    Nottingham
    British63224850002
    LENNON, Martin Hugh
    38 Twentywell Road
    Bradway
    S17 4PW Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    38 Twentywell Road
    Bradway
    S17 4PW Sheffield
    South Yorkshire
    British95748100001
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Main Street
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    Amministratore
    Main Street
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    West Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04843611
    152232750001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Segretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    British42245740001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    British42245740001
    BLACKMORE, Donald
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    British2224110001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Segretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    DAY, Simon Philip
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    Segretario
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    British71393050001
    EVANS, Clifford Stuart
    8 Myrtle Road
    MK42 0QT Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    8 Myrtle Road
    MK42 0QT Bedford
    Bedfordshire
    British40039730001
    SINCLAIR, Stuart George Hammond
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    Segretario
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    British4109700001
    SOVSHELFCO (SECRETARIAL) LIMITED
    PO BOX 8 Sovereign House
    South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    PO BOX 8 Sovereign House
    South Parade
    LS1 1HQ Leeds
    West Yorkshire
    35679850001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    British42245740001
    BETTELL, Jonathan James
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    5 Sandy Road
    MK41 9TH Bedford
    Bedfordshire
    British42245740001
    BLACKMORE, Donald
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    21 Brecon Way
    MK41 8DD Bedford
    Bedfordshire
    British2224110001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish61631390001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Amministratore
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    DAY, Simon Philip
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    23 Ash Green
    Great Chesterford
    CB10 1QR Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritish71393050001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Amministratore
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    GOODBY, David Anthony
    124 Thistle Grove
    AL7 4AQ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    124 Thistle Grove
    AL7 4AQ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British66090530001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Amministratore
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritish87102720001
    ISAACSON, Timothy John
    11 The Graylings
    Putnoe
    MK41 9BH Bedford
    Amministratore
    11 The Graylings
    Putnoe
    MK41 9BH Bedford
    British63148360001
    JENNINGS, David Frederick
    20 Wyboston Court
    Eaton Socon
    PE19 8PL St. Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    20 Wyboston Court
    Eaton Socon
    PE19 8PL St. Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish74159440001
    LEWIS, Hector Thomas
    16 Almond Close
    Barby
    CV23 8TL Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    16 Almond Close
    Barby
    CV23 8TL Rugby
    Warwickshire
    British2224140001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    MILLER, David Harry
    46 Milton Avenue
    SM1 3QE Sutton
    Surrey
    Amministratore
    46 Milton Avenue
    SM1 3QE Sutton
    Surrey
    British15488900001
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    British1729130003
    PARKINSON, Ronald
    2 Hollies Close
    SG8 7DZ Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Hollies Close
    SG8 7DZ Royston
    Hertfordshire
    British2224150001
    PELHAM, Michael Leslie
    Highfield Vicarage Road
    RG9 1HU Henley On Thames
    Oxon
    Amministratore
    Highfield Vicarage Road
    RG9 1HU Henley On Thames
    Oxon
    British3576830001
    ROBSON, Vincent Maurice
    18 Holmewood Crescent
    Holme
    PE7 3PY Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    18 Holmewood Crescent
    Holme
    PE7 3PY Peterborough
    Cambridgeshire
    British58714670001
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    SINCLAIR, Stuart George Hammond
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Kimble Lodge Holly Lane
    Silchester
    RG7 2NA Reading
    Berkshire
    British4109700001
    STEVENS, Anthony Henry Joseph
    111a Wootton Road
    PE30 4DJ Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    111a Wootton Road
    PE30 4DJ Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish67780380001

    BB & EA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 gen 2000
    Consegnato il 12 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2001Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 18 set 2001Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 117 ago 2010Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 1
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 apr 1998
    Consegnato il 22 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and bb & ea holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ago 1997
    Consegnato il 02 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 giu 1996
    Consegnato il 28 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 123/125 nathan way woolwich london t/no SGL33432 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 21 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 nov 1993
    Consegnato il 22 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land on the north side of austin fields kings lynn norfolk t/n nk 125997 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 63 and 65 london road sandy bedfordshire t/n bd 171704 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold cavendish garage richardshaw lane stanningley pudsey west yorkshire t/n wyk 512414 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land on the south east side of bennerley road bulwell nottingham nottinghamshire t/n nt 133280 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H bath road lower parkway reading berkshire t/n bk 22551 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H access house leabrook road wednesbury west midlands t/n wm 558011 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold plot 9 austin fields kings lynn norfolk t/n nk 120087 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 nov 1993
    Consegnato il 18 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 41 ellgreage street burslem stoke on trent staffordshire t/n sf 313192 and the proceeds of sale thereof together with the full benefit of all licences including any registrations.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BB & EA LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 gen 2000Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Vincent Mcloughlin
    Kpmg
    24 Blytheswood Square
    G2 3QS Glasgow
    Praticante
    Kpmg
    24 Blytheswood Square
    G2 3QS Glasgow
    Gerard Anthony Friar
    24 Blythswood Square
    Glasgow
    G2 4QS
    Praticante
    24 Blythswood Square
    Glasgow
    G2 4QS
    2
    DataTipo
    19 mar 2010Conclusione della liquidazione
    13 ott 2008Data della petizione
    13 gen 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    4
    DataTipo
    01 lug 2010Inizio della liquidazione
    18 gen 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Wood
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Praticante
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0