PEC (LIVERPOOL) LIMITED

PEC (LIVERPOOL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEC (LIVERPOOL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02703966
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    • (2224) /

    Dove si trova PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Broad Ground Road
    Lakeside
    B98 8YP Redditch
    Worcestershire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE PALATINE ENGRAVING COMPANY LIMITED18 mag 199218 mag 1992
    ADAPTPRAISE LIMITED06 apr 199206 apr 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 10-11 Broad Ground Road Lakeside Redditch Worcestershire B98 8YP in data 09 ott 2009

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    14 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    15 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine287

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed the palatine engraving company l imited\certificate issued on 02/02/06
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    18 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    18 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2002

    18 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di PEC (LIVERPOOL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    Segretario
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    BritishAccountant43547190002
    BOBST, Jean Pascal
    Ch Des Cornalles 20
    Corseaux
    Vaud 1802
    Amministratore
    Ch Des Cornalles 20
    Corseaux
    Vaud 1802
    SwissCompany Director86417270001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    Amministratore
    Millwood House
    Church Road
    CV37 0LE Snitterfield
    Warwickshire
    United KingdomBritishAccountant43547190002
    CLARKE, John Graham
    The Red Lodge Parkgate Road
    Mollington
    CH1 6NE Chester
    Segretario
    The Red Lodge Parkgate Road
    Mollington
    CH1 6NE Chester
    British42329580001
    HOCKING, John
    12 Blenheim Close
    BB1 8QL Blackburn
    Lancashire
    Segretario
    12 Blenheim Close
    BB1 8QL Blackburn
    Lancashire
    British20383980002
    WILLIAMS, Stephen Robert
    School Lane
    Knowsley Industrial Park South
    L34 9GJ Knowsley
    Merseyside
    Segretario
    School Lane
    Knowsley Industrial Park South
    L34 9GJ Knowsley
    Merseyside
    British31595990001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Ronald George
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    Amministratore
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    BritishCompany Director36193370001
    BLAKE, Alan Paul
    27 Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Merseyside
    Amministratore
    27 Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Merseyside
    BritishCompany Director14327290001
    BLAKE, Patricia Margaret
    27b Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Lancashire
    Amministratore
    27b Grosvenor Road
    Birkdale
    PR8 2ES Southport
    Lancashire
    BritishCompany Director38533590001
    BRADLEY, David
    105 Whalley Road
    Read
    BB12 7RP Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    105 Whalley Road
    Read
    BB12 7RP Burnley
    Lancashire
    BritishCompany Director27377510001
    DARRICOTTE, Geoffrey Crosland
    Beaufort House
    Edstone Court
    B95 6DD Wooton Wawen
    Warwickshire
    Amministratore
    Beaufort House
    Edstone Court
    B95 6DD Wooton Wawen
    Warwickshire
    BritishGroup Chief Exec11491410002
    LAING, Stephen George
    27 Ashburton Road
    CH43 8TN Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    27 Ashburton Road
    CH43 8TN Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritishChartered Accountant24914370001
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Amministratore
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director69716360003
    PARKER, Keith Graham
    73 Westbourne Park
    Urmston
    M41 0XR Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore
    73 Westbourne Park
    Urmston
    M41 0XR Manchester
    Greater Manchester
    BritishCompany Director43176920001
    RIDINGS, Mark Antony
    30 Bowden Green
    WR9 8WZ Droitwich Spa
    Worcestershire
    Amministratore
    30 Bowden Green
    WR9 8WZ Droitwich Spa
    Worcestershire
    United KingdomBritishManaging Director110267840001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    PEC (LIVERPOOL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 28 ago 1996
    Consegnato il 07 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the westerly side of fox street north west side of bute street and on the easterly side of douro street liverpool with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 28 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises at fox street liverpool MS274849 and MS129706. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 nov 1992
    Consegnato il 11 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge the whole of the company's undertaking property and assets including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Properties Holdings Limited
    Transazioni
    • 11 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 nov 1992
    Consegnato il 11 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge the whole of the company's undertaking peoperty and assets including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • M.B.Owen,P.W.Bullivant and S.P.Prescott
    Transazioni
    • 11 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 nov 1992
    Consegnato il 11 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge the company's undertaking property and assets including any uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Ronald George Austin
    Transazioni
    • 11 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 nov 1992
    Consegnato il 11 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Floating charge the company's undertaking property and assets including any uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • M.B.Owen,P.W.Bullivant and R.G.Austin
    Transazioni
    • 11 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 lug 1992
    Consegnato il 14 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All patents,trade marks....etc. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0