BAIN 1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBAIN 1 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02732585
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BAIN 1 LIMITED?

    • (1571) /

    Dove si trova BAIN 1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BAIN 1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WELSH COUNTRY FOODS LIMITED24 apr 199524 apr 1995
    MCINTOSH REYNOLDS LIMITED28 feb 199528 feb 1995
    WELSH COUNTRY FOODS LIMITED20 feb 199520 feb 1995
    MCINTOSH REYNOLDS LIMITED14 dic 199214 dic 1992
    MCINTOSH REYNOLDS (WALES) LIMITED07 ago 199207 ago 1992
    MADESMOKE LIMITED20 lug 199220 lug 1992

    Quali sono gli ultimi bilanci di BAIN 1 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BAIN 1 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al20 lug 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma03 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per BAIN 1 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per BAIN 1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci

    3 pagineREST-MVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 dic 2011

    2 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Dettagli del segretario cambiati per Tmf Corporate Administration Services Limited il 19 set 2011

    2 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da * Malton Bacon Factory Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Malton North Yorkshire YO17 9HG* in data 27 mag 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di Mark Steven come amministratore

    2 pagineAP01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed welsh country foods LIMITED\certificate issued on 04/05/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 mag 2011

    Risoluzione di cambio di nome della società il 19 apr 2011

    RES15
    change-of-name04 mag 2011

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Cessazione della carica di Mawlaw Secretaries Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 lug 2010

    Stato del capitale al 20 lug 2010

    • Capitale: GBP 2,810,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 22 nov 2009 al 31 dic 2009

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Jose Juan Peralta il 14 gen 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Antonius Lammers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Louis Antoine Maria Vernaus come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Stephen Ronald William Francis il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Antonius Matheus Maria Lammers il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 22 nov 2008

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BAIN 1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    6 St Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    Netherlands
    Amministratore
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    Netherlands
    Dutch129239540002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    PERALTA, Jose
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    WalesSpanish55989090003
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Segretario nominato
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Segretario
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Segretario
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    BATCHELOR, Philip
    25 Wadeson Way
    Croft
    WA3 7JW Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    25 Wadeson Way
    Croft
    WA3 7JW Warrington
    Cheshire
    British51334610001
    BURGESS, Robert
    Orme View
    3 Beach Road
    LL59 5HB Menai Bridge
    Gwynedd
    Amministratore
    Orme View
    3 Beach Road
    LL59 5HB Menai Bridge
    Gwynedd
    British56033760001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    DUNCAN, Gordon Scott
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    British33741760001
    ENNIS, Edwin Charles
    22 Abbey Road
    PE10 9EP Bourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    22 Abbey Road
    PE10 9EP Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritish116446960001
    HANGAR, Trevor
    Bowlacre Farm
    Bowlacre Road Gee Cross
    SK14 5ES Hyde
    Cheshire
    Amministratore
    Bowlacre Farm
    Bowlacre Road Gee Cross
    SK14 5ES Hyde
    Cheshire
    British98137740001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Amministratore
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    LEE, Mark Rayton
    29 The Heywoods
    CH2 2RA Chester
    Cheshire
    Amministratore
    29 The Heywoods
    CH2 2RA Chester
    Cheshire
    British58725850002
    LIND, John
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish515220001
    MCMYLER, Francis Patrick
    Porthordy Paradwys
    Paradwys
    LL62 5PE Bodorgan
    Angelsey
    Amministratore
    Porthordy Paradwys
    Paradwys
    LL62 5PE Bodorgan
    Angelsey
    British82282340001
    MITCHELL, John
    2 The Towers
    Trinity Square
    LL30 2PY Llandudno
    Amministratore
    2 The Towers
    Trinity Square
    LL30 2PY Llandudno
    British60035720006
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Amministratore
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    POCOCK, Patrick William
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    Amministratore
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    British36234170001
    PUGH, Elwyn Martin
    1 Croxdale Close
    OL7 9LJ Ashton Under Lyne
    Lancashire
    Amministratore
    1 Croxdale Close
    OL7 9LJ Ashton Under Lyne
    Lancashire
    British74903230001
    REYNOLDS, Maurice Samuel
    Cae Newydd
    Blackhorse Lane Pentraeth
    LL75 Anglesey
    Amministratore
    Cae Newydd
    Blackhorse Lane Pentraeth
    LL75 Anglesey
    British30923360001
    RHIND, Evelyn Kerr
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Amministratore
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    British389060001
    RIDOUT, Marc Alan
    37 Meliden Road
    LL19 9SD Prestatyn
    Clwyd
    Amministratore
    37 Meliden Road
    LL19 9SD Prestatyn
    Clwyd
    British42012080001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SOBEY, Michael John
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    Amministratore
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    United KingdomBritish895550001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Amministratore delegato nominato
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TRIGGS, Colin Patrick
    Crown Farm
    CW8 2HB Oakmere
    Cheshire
    Amministratore
    Crown Farm
    CW8 2HB Oakmere
    Cheshire
    United KingdomBritish193451740001
    WILLOX, Grant Alexander
    5 Charlton Court
    Hoole Road
    CH2 3PB Chester
    Amministratore
    5 Charlton Court
    Hoole Road
    CH2 3PB Chester
    British91193020002

    BAIN 1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An intercreditor and security agreement
    Creato il 30 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 08 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 08 giu 2005
    Consegnato il 18 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular - equipment comprising a warehouse storage, conveyorage and multipick system which includes: swisslog project-5 aisles (2,644 pallet positions) high bay racking, 4 stacker cranes s/no's 939569-ab, 939570-ab, 939571-ab, 939572-ab, accalon pallet conveyors for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 18 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 12 ago 2004
    Consegnato il 13 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5 aisles (2,644 pallet positions) high bay racking situated in the high bay warehouse; maintenance access platform situated in the high bay warehouse; 4 stacker cranes serial no's: 939569-ab, 939570-ab, 939571-ab, 93972-ab (for further chattel details please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 23 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the guarantee including in particular all monies due by the trustees (as defined) under or in connection with any of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 14 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 14 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mar 1995
    Consegnato il 30 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee; as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined therein) and the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of any financing document
    Brevi particolari
    Including land lying to the south of holyhead road, gaerwen, llanfihangel, esceifiog, ynys mon, isle of anglesey, gwynedd t/no. WA239861 and land lying to the south of lon groes, gaerwen industrial estate, gaerwen and land and buildings at gaerwen industrial estate, gaerwen, ynys mon, isle of anglesey, gwynedd t/no. WA658465. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ott 1992
    Consegnato il 30 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all f/h and l/h property including land lying to the soth of holyhead road, gaerwentitle no. WA239861LAND and buildings at gaerwen industrial(see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ott 1992
    Consegnato il 30 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All present and future f/h and l/h property including land lying to the south of holyhead road, gaerwen title no. WA239861 land and buildings at gaerwen industrial estate, gaerwen (including trade fixtures) (see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • James Mcintosh & Company Limited
    Transazioni
    • 30 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BAIN 1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 mar 2012Data di scioglimento
    11 mag 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0