SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED

SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOMERFIELD HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 02822431
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ILIAD INVESTMENTS LIMITED24 mag 199324 mag 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al04 gen 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il04 ott 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 gen 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso

    pagineCERTIPS

    Varie

    Forms b&z to convert to i&ps
    pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to i&ps 05/10/2010
    RES13

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 01 ott 2010

    • Capitale: GBP 2
    pagineSH01

    Nomina di Mr Stephen Parry come segretario

    pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 gen 2010

    pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Hurrell il 01 ago 2010

    pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Humes il 01 ago 2010

    pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 mag 2009

    pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2010 al 04 gen 2010

    pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ in data 20 nov 2009

    pagineAD01

    Cessazione della carica di Emily Martin come segretario

    pagineTM02

    Cessazione della carica di William Robson come amministratore

    pagineTM01

    Nomina di Mrs Caroline Jane Sellers come segretario

    pagineAP03

    legacy

    pagine363a

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine288a

    legacy

    pagine288a

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine288a

    Bilancio redatto al 26 apr 2008

    pagineAA

    legacy

    pagine363a

    Bilancio redatto al 28 apr 2007

    pagineAA

    legacy

    pagine363a

    Chi sono gli amministratori di SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PARRY, Stephen
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Segretario
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    154612550001
    SELLERS, Caroline Jane
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Governance Dept
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    146966780001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    EGITTO, Joleen
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    Segretario
    3 Abbots Close
    Whitchurch
    BS14 0UD Bristol
    British61599540001
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    GRANT, Stephen Martin
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    2 Beechwood Close
    Battledown
    GL52 6QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    Segretario
    Eastleigh Stables
    Bishopstrow
    BA12 9HW Warminster
    Wiltshire
    British91828160006
    MARTIN, Emily Louise
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    Segretario
    49 Henley Park
    Yatton
    BS49 4JJ Bristol
    British115285710001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BACK, Steven John
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    Amministratore
    Fennels 119 Bicester Road
    Lower End
    HP18 9EF Long Crendon
    United KingdomBritish85825120001
    BARRON, Michael John
    15 Oakdene Road
    TN13 3HH Sevenoaks
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    15 Oakdene Road
    TN13 3HH Sevenoaks
    Kent
    British900007620001
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    Amministratore
    70 Andes Close
    Ocean Village
    SO14 3HS Southampton
    British111624590001
    GATTO, Salvatore Martin
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    Amministratore
    11 Cavendish Lodge
    Cavendish Road
    BA1 2UD Bath
    Avon
    United KingdomBritish37327260002
    GRANT, Stephen Martin
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    3 Trelawn Court
    Rodney Road
    GL50 1JJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British20888800002
    HENSHAW, Stephen Anthony
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    2 Ashton Coombe Lower Road
    Bratton
    BA13 4JQ Westbury
    Wiltshire
    British91828160003
    MARTIN, Alan Graham
    12 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore delegato nominato
    12 Walpole Gardens
    Strawberry Hill
    TW2 5SJ Twickenham
    Middlesex
    British900007610001
    ROBSON, William Henry Mark
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    12 Kimble Close
    Knightcote
    CV47 2SJ Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish57803420002
    SHARP, Ernest Henry
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    Amministratore
    36 Tufton Court Tufton Street
    Westminster
    SW1P 3QH London
    British777200001
    SIMONS, David Martin
    Oxlease
    Wellow
    BA2 8QQ Bath
    Amministratore
    Oxlease
    Wellow
    BA2 8QQ Bath
    British33419810002
    SMITH, Neil Reynold
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    Amministratore
    27 Broom Farm Close
    Nailsea
    BS48 4YJ Bristol
    British61599510002

    SOMERFIELD HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 lug 1993
    Consegnato il 16 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company,each other group company (as defined) andany other present or future subsidiary of gateway group limited (as defined) to the chargee and/or the facility agent and/or the security agent (as defined) under the terms of each of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transazioni
    • 16 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0