THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED

THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03120897
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Colson Castors Ltd Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REVVO CASTORS LIMITED01 nov 199501 nov 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard William White come amministratore in data 18 apr 2016

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 dic 2015

    • Capitale: GBP 0.50
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 16/12/2015
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 nov 2015

    Stato del capitale al 09 nov 2015

    • Capitale: GBP 1,666,666.5
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Derrick James Towell come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Hinds come amministratore in data 01 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 nov 2014

    Stato del capitale al 10 nov 2014

    • Capitale: GBP 1,666,666.5
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Mr John Andrew Smithies come amministratore in data 04 ago 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr John Andrew Smithies come segretario in data 04 ago 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Derrick James Towell come segretario in data 04 ago 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr John Hinds come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Lilly come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard William White come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 nov 2013

    Stato del capitale al 06 nov 2013

    • Capitale: GBP 1,666,666.5
    SH01

    Cessazione della carica di Christopher Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Thomas William Blashill come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Segretario
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    190475870001
    BLASHILL, Thomas William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    United StatesAmerican181117260001
    SMITHIES, John Andrew
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    EnglandBritish153425220003
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Segretario
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    British51615270002
    MACKENZIE, Andrew
    22 Hazelton Close
    BH7 7JF Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    22 Hazelton Close
    BH7 7JF Bournemouth
    Dorset
    British107273470001
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Segretario
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    SMITH, Andrew Iain Blair
    Sunny Patch
    Martinstown
    DT2 9JN Dorchester
    Dorset
    Segretario
    Sunny Patch
    Martinstown
    DT2 9JN Dorchester
    Dorset
    British107055240003
    TOWELL, Derrick James
    Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    110
    West Midlands
    England
    Segretario
    Kineton Green Road
    B92 7EE Solihull
    110
    West Midlands
    England
    171369880002
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Segretario
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    HWP SECRETARIES LIMITED
    22 Kings Park Road
    SO15 2UF Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22 Kings Park Road
    SO15 2UF Southampton
    Hampshire
    35435540001
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    ALLEN, Paul David
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Blakenall Lane
    Leamore
    WS31HH Walsall
    70
    West Midlands
    United Kingdom
    British129651850001
    CHAHALIS, Scott
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    .
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    .
    West Midlands
    England
    UsaAmerican171371870001
    COOPER, John William
    7 Hinton Wood Avenue
    Highcliffe
    BH23 5AB Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    7 Hinton Wood Avenue
    Highcliffe
    BH23 5AB Christchurch
    Dorset
    British27311040001
    COWHIG, Timothy Joseph
    45 Carbery Avenue
    BH6 3LN Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    45 Carbery Avenue
    BH6 3LN Bournemouth
    Dorset
    British111232550001
    DAVIES, John Roger
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    8 The Grange
    Kings Bromley
    DE13 7HT Burton On Trent
    Staffordshire
    British29214160002
    DODDS, Caroline
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Harperley
    Penn Lane Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish51615270002
    HINDS, John
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    UsaAmerican185679720001
    HOLMAN, Andrew Peter
    8 Vine Farm Road
    Talbot Village
    BH12 5EN Poole
    Dorset
    Amministratore
    8 Vine Farm Road
    Talbot Village
    BH12 5EN Poole
    Dorset
    EnglandBritish124106580001
    LILLY, Robert
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    EnglandBritish97998580001
    LILLY, Robert
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    28 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritish97998580001
    MACKENZIE, Andrew
    22 Hazelton Close
    BH7 7JF Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    22 Hazelton Close
    BH7 7JF Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish107273470001
    MACKENZIE, Andrew
    22 Hazelton Close
    BH7 7JF Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    22 Hazelton Close
    BH7 7JF Bournemouth
    Dorset
    United KingdomBritish107273470001
    MAYHEAD, Clive Douglas
    The Grange
    Bagwell Lane
    RG27 8DB Winchfield
    Hampshire
    Amministratore
    The Grange
    Bagwell Lane
    RG27 8DB Winchfield
    Hampshire
    British10567100002
    PRENTICE, Hamish Murray
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    12 Rose Gate
    Aglionby
    CA4 8AJ Carlisle
    Cumbria
    British23060180001
    PRITZKER, Robert Alan
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    Amministratore
    1n Franklin Ste 2420
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60606
    Usa
    United StatesAmerican47230840001
    SANKEY, David Baldwin
    Innage House
    TF11 9AB Shifnal
    Shropshire
    Amministratore
    Innage House
    TF11 9AB Shifnal
    Shropshire
    United KingdomBritish6346070001
    SEY, James Dey Andrew
    Coppins Barnes Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RR Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Coppins Barnes Lane
    Milford On Sea
    SO41 0RR Lymington
    Hampshire
    EnglandBritish15443530001
    SMITH, Andrew Iain Blair
    Sunny Patch
    Martinstown
    DT2 9JN Dorchester
    Dorset
    Amministratore
    Sunny Patch
    Martinstown
    DT2 9JN Dorchester
    Dorset
    United KingdomBritish107055240003
    SMITH, Christopher Joseph
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    .
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    .
    West Midlands
    England
    EnglandAmerican171372130001
    TOWELL, Derrick James
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish107375020001
    TUCKER, Louhon
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    1161 Johnson Street
    Naperville 60540
    Illinois
    Usa
    United StatesAmerican98409710001
    VRESICS, John J
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    Amministratore
    22 Riderwood Road
    Barrington
    Illinois 60010
    Usa
    United StatesUsa152264500001
    WEBB, Karl
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    Amministratore
    28 Rumbush Lane
    Dickens Heath
    B90 1RA Solihull
    British83233170002
    WHITE, Richard William
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    Amministratore
    Bagnall Street
    Golds Hill
    B70 0TS West Bromwich
    C/O Colson Castors Ltd
    West Midlands
    EnglandBritish184103760001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Golds Hill
    West Bromwich
    Bagnall Street
    West Midlands
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Golds Hill
    West Bromwich
    Bagnall Street
    West Midlands
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02879952
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 mag 1998
    Consegnato il 09 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage land and premises at somerford road christchurch dorset. T/n-DT231469. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 09 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 1997
    Consegnato il 09 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The deferred consideration due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The additional property being property lying adjacent and on the west side of the first property being the land and buildings at somerford road christchurch dorset.
    Persone aventi diritto
    • Curzon Estates Limited
    Transazioni
    • 09 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 dic 1995
    Consegnato il 20 dic 1995
    In corso
    Importo garantito
    The deferred consideration to be paid by the company (formerly known as revvo castors limited) to the chargee pursuant to a transfer dated 6TH december 1995
    Brevi particolari
    Premises at somerford christchurch dorset.
    Persone aventi diritto
    • Curzon Estates Limited
    Transazioni
    • 20 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture deed
    Creato il 06 dic 1995
    Consegnato il 14 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0