THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03120897 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Colson Castors Ltd Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich West Midlands |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| REVVO CASTORS LIMITED | 01 nov 1995 | 01 nov 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard William White come amministratore in data 18 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 21 dic 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Derrick James Towell come amministratore in data 01 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di John Hinds come amministratore in data 01 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Andrew Smithies come amministratore in data 04 ago 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Andrew Smithies come segretario in data 04 ago 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Derrick James Towell come segretario in data 04 ago 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Hinds come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Lilly come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Richard William White come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Thomas William Blashill come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHIES, John Andrew | Segretario | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands | 190475870001 | |||||||
| BLASHILL, Thomas William | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | United States | American | 181117260001 | |||||
| SMITHIES, John Andrew | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands | England | British | 153425220003 | |||||
| DODDS, Caroline | Segretario | Harperley Penn Lane Tanworth In Arden B94 5HH Solihull West Midlands | British | 51615270002 | ||||||
| MACKENZIE, Andrew | Segretario | 22 Hazelton Close BH7 7JF Bournemouth Dorset | British | 107273470001 | ||||||
| PRENTICE, Hamish Murray | Segretario | 12 Rose Gate Aglionby CA4 8AJ Carlisle Cumbria | British | 23060180001 | ||||||
| SMITH, Andrew Iain Blair | Segretario | Sunny Patch Martinstown DT2 9JN Dorchester Dorset | British | 107055240003 | ||||||
| TOWELL, Derrick James | Segretario | Kineton Green Road B92 7EE Solihull 110 West Midlands England | 171369880002 | |||||||
| WEBB, Karl | Segretario | 28 Rumbush Lane Dickens Heath B90 1RA Solihull | British | 83233170002 | ||||||
| HWP SECRETARIES LIMITED | Segretario | 22 Kings Park Road SO15 2UF Southampton Hampshire | 35435540001 | |||||||
| ALLEN, Paul David | Amministratore | Blakenall Lane Leamore WS31HH Walsall 70 West Midlands United Kingdom | British | 129651850001 | ||||||
| ALLEN, Paul David | Amministratore | Blakenall Lane Leamore WS31HH Walsall 70 West Midlands United Kingdom | British | 129651850001 | ||||||
| CHAHALIS, Scott | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich . West Midlands England | Usa | American | 171371870001 | |||||
| COOPER, John William | Amministratore | 7 Hinton Wood Avenue Highcliffe BH23 5AB Christchurch Dorset | British | 27311040001 | ||||||
| COWHIG, Timothy Joseph | Amministratore | 45 Carbery Avenue BH6 3LN Bournemouth Dorset | British | 111232550001 | ||||||
| DAVIES, John Roger | Amministratore | 8 The Grange Kings Bromley DE13 7HT Burton On Trent Staffordshire | British | 29214160002 | ||||||
| DODDS, Caroline | Amministratore | Harperley Penn Lane Tanworth In Arden B94 5HH Solihull West Midlands | England | British | 51615270002 | |||||
| HINDS, John | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands | Usa | American | 185679720001 | |||||
| HOLMAN, Andrew Peter | Amministratore | 8 Vine Farm Road Talbot Village BH12 5EN Poole Dorset | England | British | 124106580001 | |||||
| LILLY, Robert | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | England | British | 97998580001 | |||||
| LILLY, Robert | Amministratore | 28 Doran Close B63 1JZ Halesowen West Midlands | England | British | 97998580001 | |||||
| MACKENZIE, Andrew | Amministratore | 22 Hazelton Close BH7 7JF Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 107273470001 | |||||
| MACKENZIE, Andrew | Amministratore | 22 Hazelton Close BH7 7JF Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | 107273470001 | |||||
| MAYHEAD, Clive Douglas | Amministratore | The Grange Bagwell Lane RG27 8DB Winchfield Hampshire | British | 10567100002 | ||||||
| PRENTICE, Hamish Murray | Amministratore | 12 Rose Gate Aglionby CA4 8AJ Carlisle Cumbria | British | 23060180001 | ||||||
| PRITZKER, Robert Alan | Amministratore | 1n Franklin Ste 2420 FOREIGN Chicago Illinois 60606 Usa | United States | American | 47230840001 | |||||
| SANKEY, David Baldwin | Amministratore | Innage House TF11 9AB Shifnal Shropshire | United Kingdom | British | 6346070001 | |||||
| SEY, James Dey Andrew | Amministratore | Coppins Barnes Lane Milford On Sea SO41 0RR Lymington Hampshire | England | British | 15443530001 | |||||
| SMITH, Andrew Iain Blair | Amministratore | Sunny Patch Martinstown DT2 9JN Dorchester Dorset | United Kingdom | British | 107055240003 | |||||
| SMITH, Christopher Joseph | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich . West Midlands England | England | American | 171372130001 | |||||
| TOWELL, Derrick James | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands England | United Kingdom | British | 107375020001 | |||||
| TUCKER, Louhon | Amministratore | 1161 Johnson Street Naperville 60540 Illinois Usa | United States | American | 98409710001 | |||||
| VRESICS, John J | Amministratore | 22 Riderwood Road Barrington Illinois 60010 Usa | United States | Usa | 152264500001 | |||||
| WEBB, Karl | Amministratore | 28 Rumbush Lane Dickens Heath B90 1RA Solihull | British | 83233170002 | ||||||
| WHITE, Richard William | Amministratore | Bagnall Street Golds Hill B70 0TS West Bromwich C/O Colson Castors Ltd West Midlands | England | British | 184103760001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castors International Ltd | 06 apr 2016 | Golds Hill West Bromwich Bagnall Street West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE REVVO CASTOR COMPANY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 06 mag 1998 Consegnato il 09 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture | |
Brevi particolari By way of legal mortgage land and premises at somerford road christchurch dorset. T/n-DT231469. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 giu 1997 Consegnato il 09 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The deferred consideration due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The additional property being property lying adjacent and on the west side of the first property being the land and buildings at somerford road christchurch dorset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 dic 1995 Consegnato il 20 dic 1995 | In corso | Importo garantito The deferred consideration to be paid by the company (formerly known as revvo castors limited) to the chargee pursuant to a transfer dated 6TH december 1995 | |
Brevi particolari Premises at somerford christchurch dorset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 06 dic 1995 Consegnato il 14 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0