CHELSEA STORES LIMITED

CHELSEA STORES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHELSEA STORES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03123019
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHELSEA STORES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CHELSEA STORES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHELSEA STORES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAISY & TOM LIMITED15 apr 199615 apr 1996
    GEOPLITE LIMITED07 nov 199507 nov 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHELSEA STORES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CHELSEA STORES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Cherry Tree Road Watford Hertfordshire WD24 6SH in data 17 apr 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 mar 2013

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 nov 2012

    Stato del capitale al 20 nov 2012

    • Capitale: GBP 13,481,699.77
    SH01

    Cessazione della carica di Neil Simon Harrington come amministratore in data 20 lug 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Harminder Singh Atwal come amministratore in data 20 lug 2012

    2 pagineAP01

    Memorandum e Statuto

    5 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Company business 11/04/2012
    RES13

    legacy

    19 pagineMG01

    Cessazione della carica di Helen Mary Bramall come segretario in data 22 feb 2012

    2 pagineTM02

    Nomina di Lynne Samatha Medini come segretario in data 22 feb 2012

    3 pagineAP03

    Bilancio redatto al 26 mar 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Joanna Boydell come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Neil Harrington come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 07 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Joanna Boydell il 01 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Helen Mary Bramall il 01 nov 2010

    1 pagineCH03

    Nomina di Mr Timothy John Ashby come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CHELSEA STORES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MEDINI, Lynne Samatha
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Segretario
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    British167184950001
    ASHBY, Timothy John
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Great BritainBritish162876770001
    ATWAL, Harminder Singh
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Amministratore
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    United KingdomBritish167976490001
    BRAMALL, Helen Mary
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    British59695650001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EMERSON, Matthew Charles
    12 Niton Road
    TW9 4LH Richmond
    Surrey
    Segretario
    12 Niton Road
    TW9 4LH Richmond
    Surrey
    British61777750001
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Segretario
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    British116097830001
    MUGRIDGE, Nicholas John
    88 Durham Road
    East Finchley
    N2 9DS London
    Segretario
    88 Durham Road
    East Finchley
    N2 9DS London
    British72460430004
    RAYNOR, Pamela Rose
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    Segretario
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    British51267950001
    SELBER, Kimberley Lynn
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    Segretario
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    Us97940820001
    THOMPSON, Nicholas Raymond
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    Segretario
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    British134102250001
    ALDWYCH SECRETARIES LIMITED
    6th Floor
    81 Aldwych
    WC2B 4RP London
    Segretario
    6th Floor
    81 Aldwych
    WC2B 4RP London
    4238520001
    BOYDELL, Joanna
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish118883430001
    BROLLY, Brian Thomas
    Kitts Quarry
    Upton Bye Burford
    OX18 4LU Burford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Kitts Quarry
    Upton Bye Burford
    OX18 4LU Burford
    Oxfordshire
    British54192370002
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Amministratore delegato nominato
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    GIFFIN, Michael William
    73c Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    Amministratore
    73c Chesilton Road
    Fulham
    SW6 5AA London
    British73418870001
    HARRINGTON, Neil Simon
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cherry Tree Road
    WD24 6SH Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish157815820001
    HOLMES, Andrew Peter Geoffrey
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    Amministratore
    51 Doneraile Street
    SW6 6EW London
    EnglandBritish21151650001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Amministratore
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    JONES, Gavin Stewart
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    Amministratore
    25 The Drive
    Henleaze
    BS9 4LD Bristol
    Avon
    EnglandBritish116097830001
    LANDERS, Brian James
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Briarbank House
    12a Childs Hill Road
    KT23 3QG Bookham Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish90246320001
    NEWMAN, Ian Kevin
    6 Greenhill Road
    GU9 8JN Farnham
    Surrey
    Amministratore
    6 Greenhill Road
    GU9 8JN Farnham
    Surrey
    British145115790001
    RAINER, Michael James
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    Amministratore
    98 Castellain Mansions
    Castellain Road
    W9 1HB London
    United KingdomBritish14442650003
    RAWNSLEY, Janet Lynn
    Heywood Cottage
    6 Clifton Street
    SK9 7NW Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Heywood Cottage
    6 Clifton Street
    SK9 7NW Alderley Edge
    Cheshire
    British101826160001
    RAYNOR, Pamela Rose
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    Amministratore
    26 Stormont Road
    N6 4NP London
    United KingdomBritish51267950001
    REVETT, Clive Edward
    53 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    53 Riversdell Close
    KT16 9JW Chertsey
    Surrey
    United KingdomBritish16023450001
    ROBERTSON, Nigel Mark Inches
    Ashworth House
    Westonbirt
    GL8 8QJ Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ashworth House
    Westonbirt
    GL8 8QJ Tetbury
    Gloucestershire
    British97170790001
    SELBER, Kimberley Lynn
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    Amministratore
    1 Bellevue Road
    Barnes
    SW13 0BJ London
    Us97940820001
    STEPHENSON, Elizabeth Jane
    92 Potter Street
    HA5 3XE Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    92 Potter Street
    HA5 3XE Pinner
    Middlesex
    British79527850001
    THOMAS, Sian Elizabeth
    1 Olive Hill Cottages
    Wick Rissington
    GL54 2PW Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    1 Olive Hill Cottages
    Wick Rissington
    GL54 2PW Cheltenham
    Gloucestershire
    British65979870001
    THOMPSON, Nicholas Raymond
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Eynella Road
    East Dulwich
    SE10 8HR London
    4
    United Kingdom
    EnglandBritish134102250001
    THOMSON, Christopher Harold William
    27 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Amministratore
    27 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    British50470780001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001
    WALSH, Wilfred Thomas
    Acorn Lodge
    Saint Huberts Lane
    SL9 7BP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Acorn Lodge
    Saint Huberts Lane
    SL9 7BP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British63955050003

    CHELSEA STORES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 26 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 ago 2006
    Consegnato il 30 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    181/183 kings road chelsea t/no BGL20895 118/124 deansgate and 44/56 king street west manchester t/no GM750858 and l/h 17/19 watergate row chester (for detailsof further properties charged please ref. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • D.C. Thomson & Company Limited
    Transazioni
    • 30 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 mar 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 giu 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £262,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The indebtedness and the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Tcs Freehold Investments Limited
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 apr 2004
    Consegnato il 15 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    181/183 kings road chelsea t/n BGL20895, 118/124 deansgate and 44/56 kkings street west manchester t/n GL750858, l/h land and buildings known as 17/19 watergate row chester, for details of further properties charged, please refer to form 39. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Secured Parties
    Transazioni
    • 15 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 mar 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 giu 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2003
    Consegnato il 31 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dc Thomson & Company Limited
    Transazioni
    • 31 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mag 2003
    Consegnato il 23 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dc Thomson & Company Limited and Quester Vct PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 dic 2002
    Consegnato il 20 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 20 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 set 2002
    Consegnato il 08 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dc Thomson & Company Limited and Quester Vct PLC
    Transazioni
    • 08 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 10 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies held in a rent deposit account under a rent deposit deed dated 02/08/02 in respect of 17-19 watergate row chester.
    Persone aventi diritto
    • Laura Ashley Limited
    Transazioni
    • 10 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 29 lug 2002
    Consegnato il 03 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interest in the deposit,as defined (in respect of the premises known as units WVL18 and WV02 weest mall bluewater kent). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Blueco Limited
    Transazioni
    • 03 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2002
    Consegnato il 11 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dc Thomson & Company Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A rent deposit deed
    Creato il 26 nov 2001
    Consegnato il 28 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a daisy & tom limited to the chargee under the lease
    Brevi particolari
    The deposit and each and every debt represented by it. An initial deposit of £262,500.
    Persone aventi diritto
    • 118-124 Deansgate Manchester Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 lug 2000
    Consegnato il 08 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the loan stock instrument
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dc Thomson & Co Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A rent deposit deed
    Creato il 17 nov 1999
    Consegnato il 26 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    The deposit or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £262,500 in an interest bearing designated account to be opened by the landlord with midland bank PLC, 1 sydney place, onslow square, south kensington, london SW7 3NW.
    Persone aventi diritto
    • Xerox Pensions Limited
    Transazioni
    • 26 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creato il 08 apr 1999
    Consegnato il 17 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brevi particolari
    Rent deposit of £49,790.
    Persone aventi diritto
    • Princes Securities Limited
    Transazioni
    • 17 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rental deposit
    Creato il 25 giu 1998
    Consegnato il 13 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of default
    Brevi particolari
    The company's interest in the deposit account as defined in the deed.
    Persone aventi diritto
    • Computer Associates PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 mar 1998
    Consegnato il 20 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 181 & 183 kings road chelsea london t/n BGL20895. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 gen 1998
    Consegnato il 04 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 118-124 (even) deansgate and 44-56 (even) king street west manchester t/n GM750858. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 nov 1997
    Consegnato il 05 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 apr 1997
    Consegnato il 26 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at 181-183 kings road, london SW3 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 18 mar 1997
    Consegnato il 05 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 18TH march 1997
    Brevi particolari
    £24,357 rent and service charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tullo Marshall Warren Limited
    Transazioni
    • 05 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 mar 1997
    Consegnato il 22 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 feb 1997
    Consegnato il 01 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £360,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The rent deposit of £360,000.
    Persone aventi diritto
    • Atlantic Speciality Retail Limited
    Transazioni
    • 01 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Agreement for lease
    Creato il 13 nov 1996
    Consegnato il 27 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £360,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of clause 5 of the agreement
    Brevi particolari
    The "performance deposit" being the sum of £360,000.
    Persone aventi diritto
    • Atlantic Speciality Retail Limited
    Transazioni
    • 27 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CHELSEA STORES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 mar 2013Inizio della liquidazione
    16 gen 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0