LASER HOTELS FOUR LIMITED

LASER HOTELS FOUR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLASER HOTELS FOUR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03165887
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o HUDSON ADVISORS UK LIMITED
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MREF HOTELS FOUR LIMITED07 feb 200707 feb 2007
    HERITAGE HOTELS LIMITED19 lug 199619 lug 1996
    245TH SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED28 feb 199628 feb 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 set 2020

    7 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 set 2019

    LRESSP

    Cessazione della carica di Vincent Frederic Marc Vernier come amministratore in data 08 lug 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vincent Vernier come segretario in data 08 lug 2019

    1 pagineTM02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 giu 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 07/06/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Timothy Selwyn Jones come amministratore in data 13 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Edward Gray come amministratore in data 24 ott 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 031658870090 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di John Brennan come amministratore in data 04 mag 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Michael Gallagher come amministratore in data 20 dic 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Darren William Guy come amministratore in data 20 dic 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent Vernier il 13 nov 2017

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Vincent Vernier come amministratore in data 06 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Vincent Vernier come segretario in data 06 ott 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Neal Morar come amministratore in data 03 ott 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Morar come segretario in data 03 ott 2017

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GALLAGHER, Michael
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    IrelandIrish243693110001
    JONES, Timothy Selwyn
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish226437520001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Segretario
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Segretario
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    197427990001
    SANDERSON, Timothy Robin Llewelyn
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Segretario
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    British69033180003
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    VERNIER, Vincent
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Segretario
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    239131660001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ALIBONE, Lee Russell
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Darnley Lodge 68 Marsh Road
    HA5 5NQ Pinner
    Middlesex
    British53633890001
    BRENNAN, John
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish211131050001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Amministratore
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritish584980007
    CARTWRIGHT, Stacey Lee
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    Amministratore
    46 Chiddingstone Road
    SW6 3TG London
    British37682070002
    CAU, Antoine Edmond Andre
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    Amministratore
    10a Durward House
    31 Kensington Court
    S8 5BH London
    French59395250002
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    Amministratore
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    ScotlandBritish104262520001
    COPELAND, Patrick Joseph
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    Amministratore
    120 Hamilton Terrace
    NW8 9UT London
    United KingdomBritish40574670003
    CRAWFORD, Guy Lindsay Macintyre
    86 Kingston Hill
    KT2 7NP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    86 Kingston Hill
    KT2 7NP Kingston Upon Thames
    Surrey
    British77508520001
    EDWARDS, Nicholas William John
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    EnglandBritish166575000001
    FERGUSON DAVIE, Charles John
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish159387570001
    FIGGE, Heiko
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish183639640001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritish120322350001
    GILBARD, Marc Edward Charles
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish29232300002
    GRATTON, David Martin
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Rosemead
    9 Chiltern Hills Road
    HP9 1PJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British71901350002
    GRAY, Robert Edward
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish188584900001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Amministratore
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish100133280001
    GUY, Darren
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish294582970001
    HALL, Steven
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Amministratore
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish147752500001
    MACDONALD, Donald John
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish557590001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Amministratore
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MARTIN, Andrew David
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Dalkeith Road
    AL5 5PP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish52743800001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Amministratore
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    EnglandBritish173110500001
    MORLEY, Ronald Martin
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Pinewood Close
    SL0 0QT Iver Heath
    Buckinghamshire
    UkBritish517180003
    PARROTT, Graham Joseph
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    Amministratore
    Flat 1 27 Redington Road
    Hampstead
    NW3 7QY London
    British6741720003
    POSTER, Stephen Michael
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    Amministratore
    46 Boileau Road
    W5 3AH London
    British67532380001
    SEDGWICK, Sarah Melanie
    42 Muncaster Road
    SW11 6NU London
    Amministratore
    42 Muncaster Road
    SW11 6NU London
    British68249060001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LASER HOTELS FOUR LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    06 apr 2016
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05893844
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LASER HOTELS FOUR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 feb 2015
    Consegnato il 26 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargobank, N.A., London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 26 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2010
    Consegnato il 03 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 1 november 2005 dated 19 october 2005 and
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 08 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole that piece of ground extending to 2 acres 2 roods and 18 poles part of the lands and farm of north berwick abbey in the parish of north berwick and county of east lothian k/a marine hotel.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 31 october 2005 and
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 05 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole rusacks hotel st andrews t/n FFE11940 including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property known as the former central club south street farnham. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H the blossoms hotel st john street chester t/no CH87315.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h property known as the bear hotel woodstock t/nos ON192408 ON166125 ON192410 ON192406 ON166127 and a portion of land adjoining bear hotel - unregistered f/h brandon hall hotel t/no WK242011 f/h castle hotel high street windsor t/no bk 261820 for details of further properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tthe Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 10 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties known as the thames lodge hotel thames street staines (including 42 and 44 thames street) and 91 and 93 gresham road staines t/n SY373030, SY551892 and SY539815 and MX397832 including all buildings erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 2003
    Consegnato il 03 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property known as the green dragon hotel (which includes 47 broad street), broad street, hereford t/no HW66342, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transazioni
    • 03 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 2003
    Consegnato il 03 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property known as blossoms hotel, st john street, chester t/no CH87315, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all servitudes and other heritable rights appurtenant thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 2003
    Consegnato il 22 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property known as bush hotel, shops and flats in the borough and 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9 and 9A south street, farnham t/no SY425153, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 2003
    Consegnato il 20 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h property k/a former central club t/n SK164707. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transazioni
    • 20 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 ott 2003
    Consegnato il 28 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties known as bear hotel woodstock oxfordshire t/n ON166127, 36 rectory lane 11, 11A and 13 market place, 5C market place, 74 oxford street t/n ON192408, t/n ON166125, t/n ON192410, ON192406 and land adjoining the bear hotel woodstock oxfordshire including all buildings erections and fixtures fittings and fixed plant. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 05 september 2003 and
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 10 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole (first) all and whole that area or piece of ground extending to two acres, two roods and eighteen poles or thereby, part of the lands and farm of north berwick abbey in the parish of north berwick and county of east lothian;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 05 september 2003 and
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 10 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole rusacks hotel, st andrews, t/n FFE11940, including all buildings, erections and fixtures and fittings and fixed plant for the time being thereon and all improvements and additions thereto;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Properties k/a the white hart hotel and numbers 2, 93 and 94 bailgate, lincoln t/nos. LL20354 and LL141872. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property k/a the new bath hotel, matlock, bath, derbyshire t/no. DY278979. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property k/a leeming house and leeming cottages, watermillock, nr penrith, cumbria t/nos. CU152326, CU164397 and CU164398. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Properties k/a white hart hotel and land adjoining land and 90 and 02 brown street, salisbury, wiltshire t/nos. WT155989, WT198683 and WT171056. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property k/a the whateley hall hotel, horsefair, banbury, oxfordshire and land lying to the west of horsefair, banbury t/nos. ON192790 and ON34875. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property k/a the eastgate hotel, high street, oxford t/no. ON207888. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Properties k/a (1) the queens hotel and queens hotel garage, imperial square, the promenade, cheltenham (2) land lying to the north east of montpellier spa road, cheltenham and (3) land and buildings on the south side of imperial square, the promenade, cheltenham t/nos. GR154133, GR183974 and GR238164 respectively. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties k/a upper reaches, thames street (including abbey mill), abingdon, oxfordshire t/no. BK103989. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 set 2003
    Consegnato il 06 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transazioni
    • 06 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LASER HOTELS FOUR LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 set 2019Inizio della liquidazione
    18 gen 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0