AD3 REALISATIONS LIMITED

AD3 REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAD3 REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03291243
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AD3 REALISATIONS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova AD3 REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AD3 REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ADAS HOLDINGS LIMITED24 feb 199724 feb 1997
    INTERCEDE 1214 LIMITED12 dic 199612 dic 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di AD3 REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per AD3 REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da Pendeford House Pendeford Business Park Pendeford Wolverhampton WV9 5AP a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 26 lug 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 05 gen 2017

    LRESEX

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 05 dic 2016

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Cessazione della carica di Charles Richard Foster Kemp come amministratore in data 20 lug 2016

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2015 al 29 mar 2015

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2015 al 30 mar 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 12 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 dic 2015

    Stato del capitale al 18 dic 2015

    • Capitale: GBP 8,960,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 12 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2015

    Stato del capitale al 06 gen 2015

    • Capitale: GBP 8,960,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    15 pagineAA

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 1

    2 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 5

    2 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 1

    2 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 5

    2 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 1

    2 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di AD3 REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARKE, Michael James
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Segretario
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    156807900001
    CLARKE, Michael James
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritishFinance Director154591790014
    SPELLER, Colin Stuart
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritishDirector84519850001
    CLARKE, Michael James
    Wergs Road
    WV6 8TQ Wolverhampton
    Woodthorne
    West Midlands
    Uk
    Segretario
    Wergs Road
    WV6 8TQ Wolverhampton
    Woodthorne
    West Midlands
    Uk
    British154592710001
    MAWBY, Trevor John Charles
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishChartered Accountant1793510001
    PALMER, Tony John
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    BritishDirector42430240002
    TUTT, Anne Catherine
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    Segretario
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    BritishFinance Director93652990001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    CLARKE, Michael James
    Wergs Road
    WV6 8TQ Wolverhampton
    Woodthorne
    West Midlands
    Amministratore
    Wergs Road
    WV6 8TQ Wolverhampton
    Woodthorne
    West Midlands
    EnglandBritishNone154591790014
    COLLIER, Stephen Howard
    Lindum
    The Green
    OX17 3NE Adderbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lindum
    The Green
    OX17 3NE Adderbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishChief Executive42290550002
    DEAN, Roger Bruce
    Downhurst Ockley Road
    Ewhurst
    GU6 7QF Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Downhurst Ockley Road
    Ewhurst
    GU6 7QF Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritishEngineering Consultant19130660001
    DOBLE, Simon James
    Appledore
    Oxenton
    GL52 9SE Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Appledore
    Oxenton
    GL52 9SE Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector120672080001
    FRAGS, William Isaac Cyril Davies
    Brynteg Forest Road
    SA48 8AN Lampeter
    Ceredigion
    Amministratore
    Brynteg Forest Road
    SA48 8AN Lampeter
    Ceredigion
    BritishDirector42069550002
    HALL, David John Logan
    Sandicroft Wonham Way
    Peaslake
    GU5 9PA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Sandicroft Wonham Way
    Peaslake
    GU5 9PA Guildford
    Surrey
    BritishDirector52254100001
    HART, Robert
    Kintail
    Brearton
    HG3 3BX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kintail
    Brearton
    HG3 3BX Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector52254080002
    KEMP, Charles Richard Foster
    Park Drive
    SW14 8RD London
    30
    Amministratore
    Park Drive
    SW14 8RD London
    30
    United KingdomBritishDirector20392890004
    LAWSON, Roger Hardman
    62 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    Amministratore
    62 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    United KingdomBritishChartered Accountant15287590001
    MAWBY, Trevor John Charles
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishChartered Accountant1793510001
    NEEDHAM, Phillip
    58 Harpsden Road
    RG9 1EG Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    58 Harpsden Road
    RG9 1EG Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishChief Executive52253960001
    PALMER, Tony John
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector42430240002
    REEVES, Barbara
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    British900004670001
    TUTT, Anne Catherine
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    Amministratore
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    BritishAccountant93652990001
    WARD, Charles John Nicholas
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector78441480001
    WATERSTONE, David
    14 Headfort Place
    SW1X 7DH London
    Amministratore
    14 Headfort Place
    SW1X 7DH London
    BritishDirector52485170003
    WINDMILL, Robert John
    3 Gunter Grove
    SW10 0UN London
    Amministratore delegato nominato
    3 Gunter Grove
    SW10 0UN London
    British900004660001

    AD3 REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 gen 2009
    Consegnato il 06 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 24 dic 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 24 dic 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 11 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 16 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 apr 2005
    Consegnato il 20 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 lug 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 24 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over cash deposit
    Creato il 18 ott 2002
    Consegnato il 22 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits credited to the charged account with the bank and any deposit or account of any other currency which derives in whole or in part from such deposits or charged account.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 24 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 apr 1997
    Consegnato il 09 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the guarantee and debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 feb 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 lug 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 24 dic 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 24 dic 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 24 dic 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 11 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    AD3 REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 mag 2018Data di scioglimento
    05 gen 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0