MITRE SECRETARIES LIMITED
Dirigente societario
Nome | MITRE SECRETARIES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 3 |
Inattivo | 136 |
Dimesso | 767 |
Totale | 906 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
NEUROLYTIC HEALTHCARE LTD | 30 lug 2020 | 31 lug 2020 | Sciolta | Segretario nominato | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England |
APTIV (UK) HOLDINGS LIMITED | 20 mag 2009 | 28 set 2009 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
APTIV (UK) HOLDINGS LIMITED | 20 mag 2009 | 15 ago 2016 | Attiva | Segretario nominato | Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place, 78 England |
INTERCEDE 2337 LIMITED | 20 mag 2009 | Sciolta | Segretario nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom | |
INTERCEDE 2338 LIMITED | 20 mag 2009 | Sciolta | Segretario nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom | |
INTERCEDE 2337 LIMITED | 20 mag 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom | |
INTERCEDE 2338 LIMITED | 20 mag 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom | |
INTERCEDE 2339 LIMITED | 20 mag 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom | |
INTERCEDE 2339 LIMITED | 20 mag 2009 | Sciolta | Segretario nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom | |
WHOLESALE COMMERCIAL COLLECTIONS LIMITED | 20 mag 2009 | 04 set 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
LANDSEC 21 LIMITED | 20 mag 2009 | 31 lug 2009 | Attiva | Segretario nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
LANDSEC 21 LIMITED | 20 mag 2009 | 31 lug 2009 | Attiva | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
DELPHI ELECTRONICS OVERSEAS COMPANY LTD | 20 mag 2009 | 15 ago 2016 | Sciolta | Segretario nominato | Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place, 78 England |
DELPHI ELECTRONICS OVERSEAS COMPANY LTD | 20 mag 2009 | 28 set 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
ALPHA HEATHROW LIMITED | 19 mag 2009 | 08 set 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
ALPHA - AIRFAYRE LIMITED | 19 mag 2009 | 08 set 2009 | Sciolta | Segretario nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
ALPHA - AIRFAYRE LIMITED | 19 mag 2009 | 08 set 2009 | Sciolta | Amministratore delegato nominato | 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London Mitre House United Kingdom |
LUMINAR NIGHTCLUBS 1 LIMITED | 21 feb 2008 | 22 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
TOYS "R" US LIMITED | 12 feb 2008 | Convertita/Chiusa | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | |
TOYS "R" US PROPERTIES (UK) LIMITED | 12 feb 2008 | Convertita/Chiusa | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | |
STROBE 12 LIMITED | 11 feb 2008 | 28 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
LUMINAR NIGHTCLUBS 2 LIMITED | 11 feb 2008 | 22 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
STROBE 10 LIMITED | 11 feb 2008 | 28 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
LUMINAR NIGHTCLUBS 3 LIMITED | 11 feb 2008 | 22 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
STROBE 11 LIMITED | 11 feb 2008 | 28 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
TIS INVESTMENTS LIMITED | 23 nov 2007 | 14 dic 2007 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SHIRES HOLDINGS LIMITED | 23 nov 2007 | 30 gen 2008 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
EMERGING MEDIA VENTURES LIMITED | 23 nov 2007 | 11 gen 2008 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SUBSEA ASSET LOCATION TECHNOLOGIES LIMITED | 23 nov 2007 | 15 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
BOTOFOGA LIMITED | 23 nov 2007 | 11 gen 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
NEENAH INTERNATIONAL UK LIMITED | 23 nov 2007 | 20 dic 2007 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
STROBE 91 LIMITED | 23 nov 2007 | 28 feb 2008 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
SENTRINO GENERAL PARTNER LIMITED | 22 nov 2007 | 10 dic 2007 | Sciolta | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
ATKINSRÉALIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 22 nov 2007 | 03 dic 2007 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
PRINCIPAL REAL ESTATE EUROPE LIMITED | 22 nov 2007 | 10 dic 2007 | Attiva | Segretario nominato | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0