ADAS INTERNATIONAL LIMITED

ADAS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADAS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03296912
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADAS INTERNATIONAL LIMITED?

    • Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ADAS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pendeford House Pendeford Business Park
    Pendeford
    WV9 5AP Wolverhampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ADAS INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ADAS LABORATORIES LIMITED27 dic 199627 dic 1996

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADAS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ADAS INTERNATIONAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ADAS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 29 mar 2015

    3 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2015 al 29 mar 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2016

    Stato del capitale al 13 gen 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2015 al 30 mar 2015

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2015

    Stato del capitale al 06 gen 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2014

    Stato del capitale al 22 gen 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Michael James Clarke il 10 ott 2012

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Micheal James Clarke il 10 ott 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Stuart Speller il 01 giu 2012

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Woodthorne Wergs Road Wolverhampton WV6 8TQ* in data 01 giu 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Micheal James Clarke il 19 gen 2012

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Micheal James Clarke il 10 gen 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ADAS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARKE, Michael James
    Pendeford Business Park
    Pendeford
    WV9 5AP Wolverhampton
    Pendeford House
    England
    Segretario
    Pendeford Business Park
    Pendeford
    WV9 5AP Wolverhampton
    Pendeford House
    England
    British154593260001
    CLARKE, Michael James
    Pendeford Business Park
    Pendeford
    WV9 5AP Wolverhampton
    Pendeford House
    England
    Amministratore
    Pendeford Business Park
    Pendeford
    WV9 5AP Wolverhampton
    Pendeford House
    England
    EnglandBritish154591790014
    SPELLER, Colin Stuart
    Pendeford Business Park
    Pendeford
    WV9 5AP Wolverhampton
    Pendeford House
    England
    Amministratore
    Pendeford Business Park
    Pendeford
    WV9 5AP Wolverhampton
    Pendeford House
    England
    EnglandBritish84519850001
    FINNIS, Jeremy Paul Godsmark
    Wyfields Farm
    Blackbush Lane Horndon On The Hill
    SS17 8PT Stanford Le Hope
    Essex
    Segretario
    Wyfields Farm
    Blackbush Lane Horndon On The Hill
    SS17 8PT Stanford Le Hope
    Essex
    British118347430001
    MAWBY, Trevor John Charles
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    British1793510001
    PALMER, Tony John
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    British42430240002
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Segretario nominato
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    TUTT, Anne Catherine
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    Segretario
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    British93652990001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    BROWN, Katharine Janet Aikman
    176 Broom Road
    TW11 9PQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    176 Broom Road
    TW11 9PQ Teddington
    Middlesex
    British51025960001
    COLLIER, Stephen Howard
    Lindum
    The Green
    OX17 3NE Adderbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lindum
    The Green
    OX17 3NE Adderbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish42290550002
    DOBLE, Simon James
    Appledore
    Oxenton
    GL52 9SE Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Appledore
    Oxenton
    GL52 9SE Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish120672080001
    DOBLE, Simon James
    Appledore
    Oxenton
    GL52 9SE Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Appledore
    Oxenton
    GL52 9SE Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish120672080001
    ELLIOTT, Paul
    149 Leathwaite Road
    SW11 6RW London
    Amministratore
    149 Leathwaite Road
    SW11 6RW London
    British51025980001
    FRAGS, William Isaac Cyril Davies
    Brynteg Forest Road
    SA48 8AN Lampeter
    Ceredigion
    Amministratore
    Brynteg Forest Road
    SA48 8AN Lampeter
    Ceredigion
    British42069550002
    HALL, David John Logan
    Sandicroft Wonham Way
    Peaslake
    GU5 9PA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Sandicroft Wonham Way
    Peaslake
    GU5 9PA Guildford
    Surrey
    British52254100001
    HART, Robert
    Kintail
    Brearton
    HG3 3BX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Kintail
    Brearton
    HG3 3BX Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish52254080002
    MAWBY, Trevor John Charles
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    18 Luard Road
    CB2 2PJ Cambridge
    Cambridgeshire
    British1793510001
    NEEDHAM, Phillip
    58 Harpsden Road
    RG9 1EG Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    58 Harpsden Road
    RG9 1EG Henley On Thames
    Oxfordshire
    British52253960001
    PALMER, Tony John
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Starsmere
    Wichenford
    WR6 6YY Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish42430240002
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Amministratore delegato nominato
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TUTT, Anne Catherine
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    Amministratore
    Windrush House
    Park Road Hook Norton
    OX15 5PX Banbury
    British93652990001
    WARD, Charles John Nicholas
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish78441480001
    WATERSTONE, David
    14 Headfort Place
    SW1X 7DH London
    Amministratore
    14 Headfort Place
    SW1X 7DH London
    British52485170003

    ADAS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 16 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 apr 2005
    Consegnato il 20 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0